WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00552578 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ancells Business Park Harvest Crescent GU51 2UZ Fleet Hampshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 353 Buckingham Avenue Slough SL1 4PF am 01. Apr. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Anthony Bass als Sekretär am 09. Dez. 2013 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard John Amos als Sekretär am 09. Dez. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Richard John Amos am 21. Nov. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard John Amos am 21. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Sadler als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Richard John Amos als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS, Neil Anthony | Sekretär | Harvest Crescent GU51 2UZ Fleet Ancells Business Park Hampshire England | 183547200001 | |||||||
| AMOS, Richard John | Geschäftsführer | Harvest Crescent GU51 2UZ Fleet Ancells Business Park Hampshire England | England | British | 67950460002 | |||||
| BASS, Neil Anthony | Geschäftsführer | Harvest Crescent GU51 2UZ Fleet Ancells Business Park Hampshire England | England | British | 70199330002 | |||||
| HUMPHREY, Christopher John | Geschäftsführer | Harvest Crescent GU51 2UZ Fleet Ancells Business Park Hampshire England | United Kingdom | British | 32877720003 | |||||
| AMOS, Richard John | Sekretär | 353 Buckingham Avenue Slough SL1 4PF | British | 149451280001 | ||||||
| COUTTS, Cheryl Jane | Sekretär | 6 Esmond Road W4 1JQ Chiswick London | British | 12016130002 | ||||||
| COX, Melanie Rachel | Sekretär | 1 The Green Bisham SL7 1RY Marlow Buckinghamshire | British | 96139050001 | ||||||
| HEMMING, Vivienne Ruth | Sekretär | 25 Saint Johns Road OX10 9AW Wallingford Oxon | British | 41962390006 | ||||||
| HUMPHREY, Christopher John | Sekretär | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | British | 32877720003 | ||||||
| SADLER, John Michael | Sekretär | 353 Buckingham Avenue Slough SL1 4PF | British | 78431540001 | ||||||
| SHAH, Bijal | Sekretär | 24 Dorset Mews Finchley N3 2BN London | British | 116421860001 | ||||||
| TIDSALL, David Peter Charles | Sekretär | 50 Anglesey Avenue Cove GU14 8SQ Farnborough Hampshire | British | 3854790001 | ||||||
| WALE, Michael Henry | Sekretär | The Lantern House 66 Camp Road SL9 7PD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 76433870001 | ||||||
| BROWN, Anthony Paul | Geschäftsführer | Two Trees 71 Foreland Road PO35 5UD Bembridge Isle Of Wight | British | 35935630001 | ||||||
| COX, George Edwin | Geschäftsführer | 53 Haw Lane Bledlow Ridge HP14 4JH High Wycombe Buckinghamshire | British | 12875030001 | ||||||
| HAWKINS, John Eric | Geschäftsführer | Craven House Hamstead Marshall RG20 0JG Newbury Berkshire | England | British | 53688120001 | |||||
| HUNT, Simon Anthony | Geschäftsführer | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | 118771650001 | ||||||
| LANG, Hugh Montgomerie | Geschäftsführer | Welders Wood Welders Lane, Chalfont St. Peter SL9 8TT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 66207680001 | |||||
| LE HOUX, Michael Angelo | Geschäftsführer | 4 Furnival Close GU25 4HR Virginia Water Surrey | British | 43860630001 | ||||||
| MELLING, Caroline Ena | Geschäftsführer | 45 Higher Drive CR8 2HQ Purley Surrey | British | 50869990001 | ||||||
| PHILLIPS, David Alan | Geschäftsführer | 16 Ryhill Way Lower Earley RG6 4AZ Reading Berkshire | British | 54616920001 | ||||||
| PLATT, John Langston | Geschäftsführer | Frog Lane Farm Frog Lane Rotherwick RG27 9BE Basingstoke Hampshire | British | 68908800001 | ||||||
| ROWLEY, Stephen Paul, Mr. | Geschäftsführer | Hadleigh 16 Sandown Road KT10 9TU Esher Surrey | United Kingdom | British | 93738770001 | |||||
| SMITH, Peter John | Geschäftsführer | Brackenhill Belper Road DE6 1LL Ashbourne Derbyshire | England | British | 7375250001 | |||||
| THORPE, David Allan | Geschäftsführer | Bobble Barn Farmhouse GL54 2ND Little Rissington Gloucestershire | United Kingdom | British | 77702540001 | |||||
| TIDSALL, David Peter Charles | Geschäftsführer | 50 Anglesey Avenue Cove GU14 8SQ Farnborough Hampshire | British | 3854790001 | ||||||
| WALE, Michael Henry | Geschäftsführer | The Lantern House 66 Camp Road SL9 7PD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 76433870001 |
Hat WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28TH november 2006 | Erstellt am 04. März 2011 Geliefert am 11. März 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Erstellt am 16. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Erstellt am 15. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 28. Nov. 2006 Geliefert am 30. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002 | Erstellt am 28. Feb. 2006 Geliefert am 02. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Jan. 2003 Geliefert am 17. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a mount lane bracknell t/n BK377482. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus letter of set-off | Erstellt am 09. Dez. 2002 Geliefert am 13. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 10. Mai 2002 Geliefert am 24. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 08. Dez. 2000 Geliefert am 21. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise) | |
Kurze Angaben The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995) | Erstellt am 09. Apr. 1999 Geliefert am 21. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. Feb. 1997 Geliefert am 27. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a rent deposit deed of even date | |
Kurze Angaben All interest in the deposit balance referred to in the rent depsoit deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 06. Okt. 1995 Geliefert am 17. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Mai 1993 Geliefert am 24. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. März 1992 Geliefert am 09. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a/ lincoln house, wellington crescent, fradley park, lichfield, staffordshire to include the company's beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. Sept. 1974 Geliefert am 26. Sept. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or p-e international LTD and/or p-e consulting group LTD. To the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H property, park house wick road, englefield green, egham, surrey. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0