WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED

WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00552578
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ancells Business Park
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Hampshire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 353 Buckingham Avenue Slough SL1 4PF am 01. Apr. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Ernennung von Mr Neil Anthony Bass als Sekretär am 09. Dez. 2013

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Richard John Amos als Sekretär am 09. Dez. 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2011

    3 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    SeitenMG01

    legacy

    6 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Richard John Amos am 21. Nov. 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Richard John Amos am 21. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von John Sadler als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Ernennung von Richard John Amos als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BASS, Neil Anthony
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    Sekretär
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    183547200001
    AMOS, Richard John
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    EnglandBritish67950460002
    BASS, Neil Anthony
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    EnglandBritish70199330002
    HUMPHREY, Christopher John
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    Harvest Crescent
    GU51 2UZ Fleet
    Ancells Business Park
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish32877720003
    AMOS, Richard John
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF
    Sekretär
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF
    British149451280001
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Sekretär
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Sekretär
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Sekretär
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    SADLER, John Michael
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF
    Sekretär
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF
    British78431540001
    SHAH, Bijal
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    Sekretär
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    British116421860001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Sekretär
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WALE, Michael Henry
    The Lantern House
    66 Camp Road
    SL9 7PD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    The Lantern House
    66 Camp Road
    SL9 7PD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British76433870001
    BROWN, Anthony Paul
    Two Trees
    71 Foreland Road
    PO35 5UD Bembridge
    Isle Of Wight
    Geschäftsführer
    Two Trees
    71 Foreland Road
    PO35 5UD Bembridge
    Isle Of Wight
    British35935630001
    COX, George Edwin
    53 Haw Lane
    Bledlow Ridge
    HP14 4JH High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    53 Haw Lane
    Bledlow Ridge
    HP14 4JH High Wycombe
    Buckinghamshire
    British12875030001
    HAWKINS, John Eric
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish53688120001
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Geschäftsführer
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    LANG, Hugh Montgomerie
    Welders Wood
    Welders Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 8TT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Welders Wood
    Welders Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 8TT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish66207680001
    LE HOUX, Michael Angelo
    4 Furnival Close
    GU25 4HR Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Furnival Close
    GU25 4HR Virginia Water
    Surrey
    British43860630001
    MELLING, Caroline Ena
    45 Higher Drive
    CR8 2HQ Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    45 Higher Drive
    CR8 2HQ Purley
    Surrey
    British50869990001
    PHILLIPS, David Alan
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British54616920001
    PLATT, John Langston
    Frog Lane Farm Frog Lane
    Rotherwick
    RG27 9BE Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Frog Lane Farm Frog Lane
    Rotherwick
    RG27 9BE Basingstoke
    Hampshire
    British68908800001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    SMITH, Peter John
    Brackenhill
    Belper Road
    DE6 1LL Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Brackenhill
    Belper Road
    DE6 1LL Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish7375250001
    THORPE, David Allan
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    United KingdomBritish77702540001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Geschäftsführer
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WALE, Michael Henry
    The Lantern House
    66 Camp Road
    SL9 7PD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Lantern House
    66 Camp Road
    SL9 7PD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British76433870001

    Hat WICK (SURREY) PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28TH november 2006
    Erstellt am 04. März 2011
    Geliefert am 11. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Erstellt am 16. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 28. Nov. 2006
    Geliefert am 30. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 02. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2003
    Geliefert am 17. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a mount lane bracknell t/n BK377482. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 13. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 10. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 08. Dez. 2000
    Geliefert am 21. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Kurze Angaben
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Erstellt am 09. Apr. 1999
    Geliefert am 21. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 20. Feb. 1997
    Geliefert am 27. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a rent deposit deed of even date
    Kurze Angaben
    All interest in the deposit balance referred to in the rent depsoit deed. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Parshott Company Limited
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Okt. 1995
    Geliefert am 17. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC(As Agent and Trustee for the Banks)
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Mai 1993
    Geliefert am 24. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 24. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 09. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a/ lincoln house, wellington crescent, fradley park, lichfield, staffordshire to include the company's beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Sept. 1974
    Geliefert am 26. Sept. 1974
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or p-e international LTD and/or p-e consulting group LTD. To the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H property, park house wick road, englefield green, egham, surrey.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdlae Bank LTD
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1974Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0