LEE COOPER (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEE COOPER (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00574307
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEE COOPER (UK) LIMITED?

    • (5141) /

    Wo befindet sich LEE COOPER (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Deloitte Llp
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LEE COOPER (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEE COOPER SPORTSWEAR LIMITED27. Jan. 198927. Jan. 1989
    LEE COOPER LIMITED16. Nov. 195616. Nov. 1956

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEE COOPER (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEE COOPER (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Sept. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2012

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten287

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    8 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Sept. 2009

    LRESEX

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 03. März 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Beschlüsse

    Resolutions
    8 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(353)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von LEE COOPER (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HANN, Indira
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    British118446370001
    BAZANTAY, Emmanuel Patrick Serge
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    Geschäftsführer
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    French140033000001
    DUNKLEY, Andrew Albert
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    EnglandBritish134204360001
    LE CLAIR, Stefaan A
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Geschäftsführer
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Belgian123657490001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Sekretär
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    FARRINGTON, David John
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    British13372050001
    LAUGHTON, Mark Timothy
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    British121239790001
    RICHARDS, Alan Jeffrey
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    British1437330001
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Sekretär
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Sekretär
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    DE LALANDE DE L'HERAUDIERE, Bruno Marie Jaques Goudon
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    Geschäftsführer
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    French121807520001
    DUTTON, Philip
    23 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    23 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish141395280001
    FARRINGTON, David John
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    British13372050001
    GERETY, James Anthony
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    Geschäftsführer
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    EnglandBritish35957840001
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    HOWELL, Christopher Timothy
    The Barn Hollybush Lane
    Flamstead
    AL3 8DG St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Barn Hollybush Lane
    Flamstead
    AL3 8DG St Albans
    Hertfordshire
    British68380170002
    KHAITAN, Ajay
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    Geschäftsführer
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    United KingdomBritish87678640006
    KING, John
    Crossley House Crossley Park
    New Pale Road
    WA6 6JG Manley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Crossley House Crossley Park
    New Pale Road
    WA6 6JG Manley
    Cheshire
    British81185040003
    LAUGHTON, Mark Timothy
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    British121239790001
    PINFIELD, Scott
    Gillmoor House
    Dukes Hill, Gill Bank Road
    LS29 0AZ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gillmoor House
    Dukes Hill, Gill Bank Road
    LS29 0AZ Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomUnknown142349020001
    RICHARDS, Alan Jeffrey
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    British1437330001
    SELBY, John Edward Robertson
    113 Rodenhurst Road
    Clapham
    SW4 8AF London
    Geschäftsführer
    113 Rodenhurst Road
    Clapham
    SW4 8AF London
    British123468550001
    SMITH, Christopher John Garner
    The Beeches
    Quill Hall Lane
    HP6 6LU Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Beeches
    Quill Hall Lane
    HP6 6LU Amersham
    Buckinghamshire
    British71402190001
    SMITH, Ian Ashley
    Malt Kiln Barn
    Halsall Road
    L39 8RN Halsall
    West Lancashire
    Geschäftsführer
    Malt Kiln Barn
    Halsall Road
    L39 8RN Halsall
    West Lancashire
    EnglandBritish4323760003
    VIDLER, Kelvin Bryan
    138 The Beeches
    Beechfield Road Boxmoor
    HP1 1PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    138 The Beeches
    Beechfield Road Boxmoor
    HP1 1PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British77933900002
    WALL, John Robert
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish72368120001
    WILSON, Duncan Thompson Hill
    10 Criss Grove
    SL9 9HG Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    10 Criss Grove
    SL9 9HG Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British30747810001
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Geschäftsführer
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003

    Hat LEE COOPER (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of variation
    Erstellt am 12. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors and/or lee cooper suisse sa to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited as Security Agent for Ge Factofrance Snc
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited ("the Security Holder")
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 15. Juni 2005
    Geliefert am 28. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies not exceeding twenty four thousand nine hundred and seventy euros and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re lee cooper (UK) limited business premium account account number 70106755. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Mai 2005
    Geliefert am 24. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lee Cooper Finance, Inc
    Transaktionen
    • 24. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 1996
    Geliefert am 16. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any of the offer facilities agreement and the refinance credit agreement and any other agreement which is included within the definitions of the financing documents and under the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Sept. 1993
    Geliefert am 06. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Apr. 1989
    Geliefert am 17. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. Nov. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set off
    Erstellt am 18. Sept. 1984
    Geliefert am 04. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or lee cooper (ireland) limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Moneys in company's accounts with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    • 18. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Jan. 1980
    Geliefert am 29. Jan. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises being factory at water-ma-trout trenethick, helston. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank LTD
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1980Registrierung einer Belastung
    Equitable charge
    Erstellt am 14. Aug. 1975
    Geliefert am 29. Aug. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from lee cooper group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Any monies standing to the credit of the company's accounts with midland bank limited.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank LTD
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1975Registrierung einer Belastung
    • 01. Nov. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LEE COOPER (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Sept. 2009Beginn der Liquidation
    23. Apr. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher James Farrington
    Deloitte Llp
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham
    Carlton Malcolm Siddle
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0