H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00575309 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?
- Großhandel mit Milchprodukten, Eiern und Speiseölen und -fetten (46330) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jan Egtved Pedersen am 06. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Lauritzen am 06. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Tanjot Soar am 06. Dez. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOAR, Tanjot | Sekretär | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire | British | 123350000001 | ||||||
| LAURITZEN, Peter | Geschäftsführer | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire | England | Danish | 123354600001 | |||||
| PEDERSEN, Jan Egtved | Geschäftsführer | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire | England | Danish | 123347470001 | |||||
| BALL, Ute Suse | Sekretär | 60 Sycamore Drive LE6 0EW Groby Leicestershire | British | 118371550001 | ||||||
| BANCROFT, Lynne Deborah | Sekretär | Playstole Chapel Lane Sissinghurst TN17 2JN Cranbrook Kent | British | 70267830001 | ||||||
| JARVIS, Peter James | Sekretär | 184 Riddlesdown Road CR8 1DF Purley Surrey | British | 54493370001 | ||||||
| PRICE, John Philip | Sekretär | 20 Rossmore Court Park Road NW1 6XX London | British | 51592560002 | ||||||
| RAMSDEN, Andrew Nicholas | Sekretär | The Old Forge Fall House Lane WF12 0NJ Dewsbury West Yorkshire | British | 74484590001 | ||||||
| REYNOLDS, Andrew David Finch | Sekretär | 25 Franconia Road Clapham SW4 9NB London | British | 63987530001 | ||||||
| YATES, Gordon | Sekretär | 3 Cornwallis Avenue CT6 6UQ Herne Bay Kent | British | 10502580001 | ||||||
| ALLIKER, Anthony John | Geschäftsführer | Treetops 508 Loose Road ME15 9UF Maidstone Kent | British | 10502610001 | ||||||
| BANCROFT, Lynne Deborah | Geschäftsführer | Playstole Chapel Lane Sissinghurst TN17 2JN Cranbrook Kent | England | British | 70267830001 | |||||
| CHRISTIANSEN, Mikael | Geschäftsführer | Tarran Barn Hazelheads Lane HG5 0NX Knaresborough North Yorkshire | Danish | 89938470001 | ||||||
| CLARKE, Peter James | Geschäftsführer | 21 Fennel Close Dickens Place ME1 1LW Rochester Kent | British | 91221920001 | ||||||
| DAVIDSON, Richard Colin Neil | Geschäftsführer | Maplewell Farm Maplewell Road LE12 8QY Woodhouse Eaves Leicestershire | United Kingdom | British | 110114680001 | |||||
| EARPS, David Ian | Geschäftsführer | 39 Dovedale Road West Bridgford NG2 6JB Nottingham Nottinghamshire | England | British | 74248350001 | |||||
| GILBERT, Martin James | Geschäftsführer | 10 Knowle Green S17 3AP Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 65655390002 | |||||
| HEASMAN, Paul William | Geschäftsführer | 7 Kesteven Close Halling ME2 1LZ Rochester Kent | British | 82924260001 | ||||||
| INKPIN, Grant Roger | Geschäftsführer | Yew Tree House Wetherby Road LS22 4EP Wetherby West Yorkshire | British | 76825990001 | ||||||
| JARVIS, Peter James | Geschäftsführer | 184 Riddlesdown Road CR8 1DF Purley Surrey | England | British | 54493370001 | |||||
| JONES, Roger Francis | Geschäftsführer | 8 Northbrook Drive HA6 2YU Northwood Middlesex | England | British | 84336140001 | |||||
| KIRKPATRICK, Peter John | Geschäftsführer | 30 Ennerdale Drive Aughton L39 5HF Ormskirk Lancashire | British | 65033740001 | ||||||
| MORTENSEN, Ib | Geschäftsführer | Oak Beams Montreal Road TN13 2EP Sevenoaks Kent | Danish | 92120800001 | ||||||
| PEET, Nigel David | Geschäftsführer | 49 Heworth Village YO31 1AE York | United Kingdom | British | 26623160002 | |||||
| POPE, Charles Philip Torrington | Geschäftsführer | 17 Festival Avenue DA3 7HR New Barn Kent | British | 72399120001 | ||||||
| PRESTON, Frederick Alan | Geschäftsführer | Birchwood 73 Tunbury Avenue Walderslade ME5 9EJ Chatham Kent | British | 56295570001 | ||||||
| RAMSDEN, Andrew Nicholas | Geschäftsführer | The Old Forge Fall House Lane WF12 0NJ Dewsbury West Yorkshire | British | 74484590001 | ||||||
| SALKELD, David John | Geschäftsführer | The Old Hall Back Lane Bramham LS23 6QR Wetherby West Yorkshire | England | British | 111995510001 | |||||
| SMITH, Timothy John | Geschäftsführer | Swanland Lodge West End, Swanland HU14 3PE Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | 84729640001 | |||||
| VON MUHLENEN, Roger | Geschäftsführer | Ch-3186 Dudingen FOREIGN Switzerland | Swiss | 10502620001 | ||||||
| WEBB, Anne Marie | Geschäftsführer | The Hermitage Les Maindonnaux St Martin Guernsey Channel Islands | Swedish | 9818800002 | ||||||
| WEBB, John Ernest | Geschäftsführer | The Hermitage Les Maindonnaux GY4 6AH St Martin Guernsey Channel Islands | British | 9818790004 |
Hat H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 04. Nov. 1998 Geliefert am 10. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 27. Nov. 1995 Geliefert am 14. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land at springhead orchard springhead enterprise park northfleet kent with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Apr. 1991 Geliefert am 26. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land at spring head enterprise park springhead road northfleet kent t/n k 696044 and assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 29. Aug. 1990 Geliefert am 04. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Apr. 1984 Geliefert am 19. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £140,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. März 1980 Geliefert am 20. März 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings 336 st james road, camberwell, london SE1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0