J.ARMSTRONG TODD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | J.ARMSTRONG TODD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00578134 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von J.ARMSTRONG TODD LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich J.ARMSTRONG TODD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 21 Wansbeck Business Park Rotary Way NE63 8QW Ashington Northumberland |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J.ARMSTRONG TODD LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für J.ARMSTRONG TODD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Sean Mc Keown am 04. Mai 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gareth Sean Mc Keown am 04. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Declan Gerard Canavan am 04. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Peter Burns am 04. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2005 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2004 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s |
Wer sind die Geschäftsführer von J.ARMSTRONG TODD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC KEOWN, Gareth Sean | Sekretär | 11 Lake Road Cullyhanna BT35 0LR Newry Co Down | Irish | Accountant | 113780990001 | |||||
BURNS, John Peter | Geschäftsführer | Pine Lodge 27 Portadown Road BT61 9EE Armagh County Armagh | Northern Ireland | British | Flooring Contractor | 144357590001 | ||||
CANAVAN, Declan Gerard | Geschäftsführer | Ashtree House 4c Old Road Poyntzpass BT35 6TQ Newry County Down | United Kingdom | Irish | Quantity Surveyor | 145386800001 | ||||
MC KEOWN, Gareth Sean | Geschäftsführer | 11 Lake Road Cullyhanna BT35 0LR Newry Co Down | United Kingdom | Irish | Accountant | 113780990001 | ||||
BELL, Malcolm Peter | Sekretär | 26 Moor Lane NE20 9AD Darras Hall Newcastle Upon Tyne | British | 98010750001 | ||||||
MERRON, Imelda Anne | Sekretär | 12 The Glen BT35 8BS Newry County Down | Irish | Company Director | 82517680002 | |||||
PORTEOUS, Gavin | Sekretär | Highcroft Elvaston Road NE46 2HH Hexham Northumberland | British | 10800520002 | ||||||
BELL, Malcolm Peter | Geschäftsführer | 26 Moor Lane NE20 9AD Darras Hall Newcastle Upon Tyne | British | Business Manager | 98010750001 | |||||
CLARKSON, Joseph | Geschäftsführer | 26 Otterburn Avenue South Wellfield NE25 9QL Whitley Bay Tyne & Wear | British | Flooring Contractor | 10800570001 | |||||
CLARKSON, Norah | Geschäftsführer | 26 Otterburn Avenue South Wellfield NE25 9QL Whitley Bay Tyne & Wear | British | Married Woman | 10800540001 | |||||
CLARKSON, Peter | Geschäftsführer | Teachers Cottage Ordley Village NE46 1SX Hexham Northumberland | British | Flooring Contractor | 10800550001 | |||||
LOGAN, Robert Carr | Geschäftsführer | 93 Beach Road Tynemouth NE30 2TR North Shields Tyne & Wear | British | Business Manager | 101154020001 | |||||
MERRON, Imelda Anne | Geschäftsführer | 12 The Glen BT35 8BS Newry County Down | Irish | Company Secretary | 82517680002 |
Hat J.ARMSTRONG TODD LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 01. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £650,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1995 Geliefert am 10. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of malcolm peter bell | |
Kurze Angaben Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1995 Geliefert am 10. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of joseph clarkson | |
Kurze Angaben Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1995 Geliefert am 10. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of peter clarkson | |
Kurze Angaben Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1995 Geliefert am 10. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of norah clarkson | |
Kurze Angaben Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1983 Geliefert am 05. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold unit 1B north tyne industrial estate, whitley road, longbenton, tyne and wear. Title no. Ty 19873. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 12. Jan. 1981 Geliefert am 16. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3,711.50 & further advances not exceeding £4,500 in aggregate | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Mai 1979 Geliefert am 29. Mai 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, goodwill & uncalled capital with all buildings, fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Aug. 1978 Geliefert am 01. Sept. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land situate in or near stowell street, newcastle upon tyne, with buildings and premises erected thereon and known as nordon house. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0