J.ARMSTRONG TODD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ.ARMSTRONG TODD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00578134
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J.ARMSTRONG TODD LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich J.ARMSTRONG TODD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 21 Wansbeck Business Park
    Rotary Way
    NE63 8QW Ashington
    Northumberland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J.ARMSTRONG TODD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für J.ARMSTRONG TODD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 21. Juni 2011

    • Kapital: GBP 20,000
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Sean Mc Keown am 04. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Gareth Sean Mc Keown am 04. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Declan Gerard Canavan am 04. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Peter Burns am 04. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2006

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2004

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von J.ARMSTRONG TODD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MC KEOWN, Gareth Sean
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    Sekretär
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    IrishAccountant113780990001
    BURNS, John Peter
    Pine Lodge
    27 Portadown Road
    BT61 9EE Armagh
    County Armagh
    Geschäftsführer
    Pine Lodge
    27 Portadown Road
    BT61 9EE Armagh
    County Armagh
    Northern IrelandBritishFlooring Contractor144357590001
    CANAVAN, Declan Gerard
    Ashtree House
    4c Old Road Poyntzpass
    BT35 6TQ Newry
    County Down
    Geschäftsführer
    Ashtree House
    4c Old Road Poyntzpass
    BT35 6TQ Newry
    County Down
    United KingdomIrishQuantity Surveyor145386800001
    MC KEOWN, Gareth Sean
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    Geschäftsführer
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    United KingdomIrishAccountant113780990001
    BELL, Malcolm Peter
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    British98010750001
    MERRON, Imelda Anne
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    Sekretär
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    IrishCompany Director82517680002
    PORTEOUS, Gavin
    Highcroft Elvaston Road
    NE46 2HH Hexham
    Northumberland
    Sekretär
    Highcroft Elvaston Road
    NE46 2HH Hexham
    Northumberland
    British10800520002
    BELL, Malcolm Peter
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    BritishBusiness Manager98010750001
    CLARKSON, Joseph
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishFlooring Contractor10800570001
    CLARKSON, Norah
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishMarried Woman10800540001
    CLARKSON, Peter
    Teachers Cottage
    Ordley Village
    NE46 1SX Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Teachers Cottage
    Ordley Village
    NE46 1SX Hexham
    Northumberland
    BritishFlooring Contractor10800550001
    LOGAN, Robert Carr
    93 Beach Road
    Tynemouth
    NE30 2TR North Shields
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    93 Beach Road
    Tynemouth
    NE30 2TR North Shields
    Tyne & Wear
    BritishBusiness Manager101154020001
    MERRON, Imelda Anne
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    Geschäftsführer
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    IrishCompany Secretary82517680002

    Hat J.ARMSTRONG TODD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 01. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £650,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 01. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 1995
    Geliefert am 10. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of malcolm peter bell
    Kurze Angaben
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Malcolm Peter Bell
    Transaktionen
    • 10. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 1995
    Geliefert am 10. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of joseph clarkson
    Kurze Angaben
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Joseph Clarkson
    Transaktionen
    • 10. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 1995
    Geliefert am 10. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of peter clarkson
    Kurze Angaben
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Peter Clarkson
    Transaktionen
    • 10. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 1995
    Geliefert am 10. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of norah clarkson
    Kurze Angaben
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Norah Clarkson
    Transaktionen
    • 10. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 1983
    Geliefert am 05. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold unit 1B north tyne industrial estate, whitley road, longbenton, tyne and wear. Title no. Ty 19873.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 12. Jan. 1981
    Geliefert am 16. Jan. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £3,711.50 & further advances not exceeding £4,500 in aggregate
    Kurze Angaben
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • The Counil of the City of Newcastle upon Tyne
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1981Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 23. Mai 1979
    Geliefert am 29. Mai 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, goodwill & uncalled capital with all buildings, fixtures fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 1979Registrierung einer Belastung
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Aug. 1978
    Geliefert am 01. Sept. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land situate in or near stowell street, newcastle upon tyne, with buildings and premises erected thereon and known as nordon house.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1978Registrierung einer Belastung
    • 27. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0