GALLPEN PRESS LIMITED(THE)
Überblick
Unternehmensname | GALLPEN PRESS LIMITED(THE) |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00581255 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GALLPEN PRESS LIMITED(THE)?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich GALLPEN PRESS LIMITED(THE)?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Starling Road Norwich NR3 3EL Norfolk |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GALLPEN PRESS LIMITED(THE)?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GALLPEN PRESS LIMITED(THE)?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Russell Healey as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Notification of Michael Grapes as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Russell David Healey am 05. Apr. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Kevin Grapes am 05. Apr. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Russell David Healey am 05. Apr. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Russell David Healey am 19. Juni 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Russell David Healey am 19. Juni 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GALLPEN PRESS LIMITED(THE)?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEALEY, Russell David | Sekretär | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | British | Company Director | 37791180001 | |||||
GRAPES, Michael Kevin | Geschäftsführer | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | United Kingdom | British | Travel Agent | 13902740004 | ||||
HEALEY, Russell David | Geschäftsführer | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | England | British | Accountant | 37791180002 | ||||
CATCHPOLE, Linnie | Sekretär | 514 Hall Road NR4 6NQ Norwich Norfolk | British | Accountant | 35278370001 | |||||
METCALF, Andrew John | Sekretär | 115 Plantation Road Hellesdon NR6 5RH Norwich Norfolk | British | 15538250001 | ||||||
YOUNGS, Ian David | Sekretär | Corner Barn Chapel Road East Ruston NR12 9AA Norwich Norfolk | British | Company Secretary | 38399120002 | |||||
YOUNGS, Paul Francis | Sekretär | Miander Sylvan Way Blofield Heath NR13 4QL Norwich | British | 15538270002 | ||||||
GRINT, Anthony James | Geschäftsführer | 42 Mountfield Avenue Hellesdon NR6 5HW Norwich Norfolk | British | Printer | 15538280001 | |||||
GRINT, Robert Melvin | Geschäftsführer | 66 Reepham Road NR6 5LT Norwich Norfolk | British | Company Director | 32221370001 | |||||
HANNER, David John | Geschäftsführer | 60 High House Avenue NR18 0JN Wymondham Norfolk | British | Production Director | 37118780001 | |||||
HEWITT, Bernard Keith | Geschäftsführer | The Flat Langley Grange Langley Norwich Norfolk | British | Printer | 15538290001 | |||||
METCALF, Andrew John | Geschäftsführer | 115 Plantation Road Hellesdon NR6 5RH Norwich Norfolk | British | Printer | 15538250001 | |||||
MOSS, Peter John | Geschäftsführer | 117 Kipling Way IP14 1TS Stowmarket Suffolk | England | British | Sales Director | 37118680001 | ||||
READ, Edward Julian | Geschäftsführer | 108 Trafford Road NR1 2QR Norwich Norfolk | England | British | Commercial Director | 37118600001 | ||||
YOUNGS, Ian David | Geschäftsführer | Corner Barn Chapel Road East Ruston NR12 9AA Norwich Norfolk | British | Financial Director | 38399120002 | |||||
YOUNGS, Paul Francis | Geschäftsführer | Miander Sylvan Way Blofield Heath NR13 4QL Norwich | British | Printer | 15538270002 | |||||
YOUNGS, Simon John | Geschäftsführer | 4 Breydeston Cottages Blofield NR13 4LN Norwich Norfolk | British | Estimator | 48223750001 | |||||
YOUNGS, Stanley Francis Alfred | Geschäftsführer | Cuttons Corner Hemblington NR13 4PS Norwich Norfolk | British | Printer | 12578980001 | |||||
YOUNGS, Tamara Lynn | Geschäftsführer | Miander Sylvan Way, Blofield NR13 4QL Norwich Norfolk | British | Accountant | 69540110001 | |||||
YOUNGS, Valerie Patricia | Geschäftsführer | Homefields Cuttons Corner Hemblington NR13 4PS Norwich Norfolk | British | Secretary | 15538260001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GALLPEN PRESS LIMITED(THE)?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Michael Kevin Grapes | 06. Apr. 2016 | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Russell David Healey | 06. Apr. 2016 | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat GALLPEN PRESS LIMITED(THE) Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 12. Juli 2005 Geliefert am 21. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 24. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the plant and machinery vehicles computers and other equipment being the agfa apogee X45 e semi automatic (serial no 105). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 24. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 10. Juli 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Mai 1995 Geliefert am 02. Juni 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of chattel mortgage | Erstellt am 28. Juni 1993 Geliefert am 30. Juni 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease agreement | |
Kurze Angaben 1985 heidelberg mozp printing press serial no.606738. 1990 heidelberg single colour gto printing press serial no.702046. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 04. Juni 1992 Geliefert am 10. Juni 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £11000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Kurze Angaben Serial nos 456.000.00 249 scantext 2030 ddc imagesetter. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 11. Dez. 1989 Geliefert am 13. Dez. 1989 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £90,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben See schedule attached to form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Juni 1989 Geliefert am 12. Juli 1989 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0