S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED

S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameS. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00584040
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    UHY HACKER YOUNG LLP
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    EW1 YW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Nov. 2011

    9 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kemp House, Cumnor Hill Oxford Oxfordshire OX2 9PH am 14. Dez. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Nov. 2010

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 06. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 37,001
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Dezider Kemp als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    7 Seiten155(6)a

    legacy

    6 Seiten155(6)a

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    14 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Sekretär
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglishFinancial Director15662110002
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglishAccountant15662110002
    FINEMAN, Simon
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    Geschäftsführer
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    EnglandBritishDirector61133550002
    CLOUGH, Geoffrey Edmund
    46 Laurel Drive
    Southmoor
    OX13 5DJ Abingdon
    Oxfordshire
    Sekretär
    46 Laurel Drive
    Southmoor
    OX13 5DJ Abingdon
    Oxfordshire
    British64816510001
    GROSSMAN, David Brian
    28 The Drive
    HA8 8PT Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    28 The Drive
    HA8 8PT Edgware
    Middlesex
    British8167360001
    GROSSMAN, David Brian
    28 The Drive
    HA8 8PT Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    28 The Drive
    HA8 8PT Edgware
    Middlesex
    British8167360001
    BARNES, Keith Harold
    28 Barley Down Drive
    SO22 4LS Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    28 Barley Down Drive
    SO22 4LS Winchester
    Hampshire
    BritishDirector26956260002
    BOSTON, Neil Moir, Mr.
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector113486000001
    BUCKLEY-RYAN, Nigel
    Gullrock
    4 Carisbrooke Way, Kingsmead
    MK4 4BB Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Gullrock
    4 Carisbrooke Way, Kingsmead
    MK4 4BB Milton Keynes
    BritishBusiness Development Panel Pro29168790003
    BULL, Keith
    Cottage Farm Bungalow
    Chapel Lane
    NG14 6AQ Epperstone
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Cottage Farm Bungalow
    Chapel Lane
    NG14 6AQ Epperstone
    Nottinghamshire
    BritishDirector37955300001
    CARSON, Patrick John Buckler
    Beech Hanger House Harestone Lane
    CR3 6BD Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beech Hanger House Harestone Lane
    CR3 6BD Caterham
    Surrey
    BritishAcct2119210002
    CHAMBERS, Nicholas James
    Grays Cottage
    120 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxon
    Geschäftsführer
    Grays Cottage
    120 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxon
    BritishDirector26956270002
    GROSSMAN, David Brian
    28 The Drive
    HA8 8PT Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    28 The Drive
    HA8 8PT Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritishFinancial Accountant8167360001
    IGRA, Bernard Maurice
    Combe Hill
    Lustleigh
    TQ13 9TN Newton Abbot
    Devon
    Geschäftsführer
    Combe Hill
    Lustleigh
    TQ13 9TN Newton Abbot
    Devon
    BritishCertified Accountant8167380001
    KEMP, Dezider Daniel
    4 Paddox Close
    Squitchey Lane
    OX2 7LR Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    4 Paddox Close
    Squitchey Lane
    OX2 7LR Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector13458820001
    LAWRENCE, Alfred Frederick
    15 Mons Avenue
    CM11 2HG Billericay
    Essex
    Geschäftsführer
    15 Mons Avenue
    CM11 2HG Billericay
    Essex
    BritishDirector26956280001
    SILVERMAN, Alfons
    45 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    45 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector8167400001
    SILVERMAN, Ella
    45 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    45 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector8167410001
    SILVERMAN, Mark Trevor
    Green Trees
    Pynnacles Close
    HA7 4AF Stanmore
    Middx
    Geschäftsführer
    Green Trees
    Pynnacles Close
    HA7 4AF Stanmore
    Middx
    United KingdomBritishDirector103585600001
    SILVERMAN, Michelle
    23 London Road
    HA7 4PA Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    23 London Road
    HA7 4PA Stanmore
    Middlesex
    BritishNon Executive53214150001
    STANTON, Ralph Robert
    5 Barn Rise
    HA9 9NA Wembley
    Middlesex
    Geschäftsführer
    5 Barn Rise
    HA9 9NA Wembley
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector26956290001
    THEWLIS, Clive Roger
    11 Rowney Gardens
    CM21 0AT Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    11 Rowney Gardens
    CM21 0AT Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant80916130001

    Hat S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All assets debenture
    Erstellt am 05. Nov. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Sept. 2003
    Geliefert am 20. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 45,macadam way,west portway industrial estate,andover,hampshire t/no HP602154.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south side of bentalls, pipps hill industrial area, basildon, essex, t/n EX243298.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Sept. 2003
    Geliefert am 11. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £60,00O.
    Berechtigte Personen
    • Van Geel UK Limited
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/A property k/a plot 5 macadam way west portway industrial estate andover. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on book debts
    Erstellt am 09. Aug. 2000
    Geliefert am 12. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts and monetary claims (except those vesting in cid under the invoice discounting agreement) including deposits and credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Juni 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as bentalls pipps hill industrial estate, basildon essex. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1997
    Geliefert am 10. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 1 wentworth road heathfield newton abbott devon t/no.DN258506 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1997
    Geliefert am 10. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at harvey road burnt mill industrial area basildon essex t/no.EX416804 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1997
    Geliefert am 10. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a warehouses offices and premises situated between endle street and ryde terrace southampton hampshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Geliefert am 27. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £32,549.29 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All rights, title and interest to all sums payable under the insurance particulars. See form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 27. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Jan. 1989
    Geliefert am 28. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or selectwood LTD to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H unit 1 wentworth road cross grange trading estate heathfield newton abbott devon.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1989Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1988
    Geliefert am 17. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H warehouse and office premises situated between endle street and ryde terrace southampton.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1988
    Geliefert am 17. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H warehouse premises and land at harvey road, burnt mill industrial estate, basildon, essex.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 13. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Sept. 1986
    Geliefert am 16. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold - land to the south side of harvey road, burnt mills industrial estate, basilton, essex. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Jan. 1984
    Geliefert am 19. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of cheshire street bethnal green, tower hamlets ( st mathias old c e school) title no ln 182014 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Jan. 1984
    Geliefert am 19. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    35 and 37 cheshire street, and 62, 64, 66 and 68 kerbela street, tower hamlets. Title no 447967, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 16. Jan. 1984
    Geliefert am 19. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part of st mathias church site, chilton street, bethnal green, tower hamlets. Title no. Ln 163818. and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Okt. 1972
    Geliefert am 19. Okt. 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ryde terrace & endle street, southampton. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1972Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat S. SILVERMAN & SON (IMPORTERS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Nov. 2010Beginn der Liquidation
    24. Aug. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praktiker
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praktiker
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0