CLAY GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCLAY GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00589132
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CLAY GROUP LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich CLAY GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Quadrant House
    17 Thomas More Street
    E1W 1YW Thomas Moore Square
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CLAY GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WINGLAW GROUP LIMITED20. Jan. 198420. Jan. 1984
    WINGLAW PROPERTIES LIMITED20. Aug. 195720. Aug. 1957

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLAY GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für CLAY GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. März 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Jan. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juli 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Jan. 2009

    5 Seiten4.68

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    1 Seiten287

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    13 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    11 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2003

    12 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2002

    12 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von CLAY GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Sekretär
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Geschäftsführer
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    ANDREWS, Leslie
    Holly Tree House
    3 Whiteheads Lane
    BA15 1JU Bradford On Avon
    Wiltshire
    Sekretär
    Holly Tree House
    3 Whiteheads Lane
    BA15 1JU Bradford On Avon
    Wiltshire
    British2687900002
    ANDREWS, Leslie
    Holly Tree House
    3 Whiteheads Lane
    BA15 1JU Bradford On Avon
    Wiltshire
    Sekretär
    Holly Tree House
    3 Whiteheads Lane
    BA15 1JU Bradford On Avon
    Wiltshire
    British2687900002
    WREN, Maurice Arthur
    3 Sea Reach
    SS9 1BL Leigh On Sea
    Essex
    Sekretär
    3 Sea Reach
    SS9 1BL Leigh On Sea
    Essex
    British40376650001
    WREN, Maurice Arthur
    3 Sea Reach
    SS9 1BL Leigh On Sea
    Essex
    Sekretär
    3 Sea Reach
    SS9 1BL Leigh On Sea
    Essex
    British40376650001
    YATES, Martin Thomas Readman
    31 Goldon
    SG6 2NA Letchworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    31 Goldon
    SG6 2NA Letchworth
    Hertfordshire
    British7948780001
    ANDREWS, Leslie
    Holly Tree House
    3 Whiteheads Lane
    BA15 1JU Bradford On Avon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    3 Whiteheads Lane
    BA15 1JU Bradford On Avon
    Wiltshire
    British2687900002
    ANDREWS, Peter Frederick Charles
    1 Parkside Avenue
    Wimbledon
    SW19 5ES London
    Geschäftsführer
    1 Parkside Avenue
    Wimbledon
    SW19 5ES London
    British23847760002
    BATTY, Andrew Nicholson
    43 Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    43 Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70372090001
    EDWARDS, David Lindsey
    4 Rosebury Drive
    Bisley
    GU24 9RX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Rosebury Drive
    Bisley
    GU24 9RX Woking
    Surrey
    British53245050002
    EMERY, Peter Frank Hannibal, The Rt. Hon. Sir
    8 Ponsonby Terrace
    SW18 4QA London
    Geschäftsführer
    8 Ponsonby Terrace
    SW18 4QA London
    British91535730001
    ESFANDI, Joseph
    85 Addison Road
    W14 8ED London
    Geschäftsführer
    85 Addison Road
    W14 8ED London
    British9464260001
    FIDGEN, Roger Stewart
    The Well House
    Stratfield Saye
    RG7 2DJ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Well House
    Stratfield Saye
    RG7 2DJ Reading
    Berkshire
    British42949000001
    GUISE, Christopher James
    Easton Town Farm
    Sherston
    SN16 0PS Malmesbury
    Wilts
    Geschäftsführer
    Easton Town Farm
    Sherston
    SN16 0PS Malmesbury
    Wilts
    British27816680001
    NEILL, James Smart
    Acre Nook 53 Townsend Lane
    AL5 2RE Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Acre Nook 53 Townsend Lane
    AL5 2RE Harpenden
    Hertfordshire
    British18750140001
    OLIVER, William Alder
    8 Cambrian Close
    GU15 3LD Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Cambrian Close
    GU15 3LD Camberley
    Surrey
    British35518250001
    RIDAL, Philip Martin
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish79892010001
    SHAW, Derek Winston
    The Old Vicarage Swineshead
    PE20 3JA Boston
    Lincs
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage Swineshead
    PE20 3JA Boston
    Lincs
    British8852840001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WINHAM, Basil Arthur
    Flat 7 22 Eaton Square
    SW1W 9DE London
    Geschäftsführer
    Flat 7 22 Eaton Square
    SW1W 9DE London
    British96570410001
    WREN, Maurice Arthur
    3 Sea Reach
    SS9 1BL Leigh On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    3 Sea Reach
    SS9 1BL Leigh On Sea
    Essex
    British40376650001

    Hat CLAY GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Memorandum of deposit of securities
    Erstellt am 10. Juli 1997
    Geliefert am 22. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The securities together with all other stocks shares bonds or other securities ay any time deposted with or transferred to the bank otr it's nominees by the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit of securities
    Erstellt am 31. Juli 1996
    Geliefert am 06. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The securities deposited with or transferred to the depositee by the depositor being:- 750,000 ordinary shares of 25P each in dwyer estates PLC.
    Berechtigte Personen
    • Dukeminster Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 09. Feb. 1995
    Geliefert am 13. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the memorandum of deposit
    Kurze Angaben
    1,700,000 ordinary shares of 25P each in dwyer estates PLC and any other securities deposited or transferred by the company to the depositee including any bonus stock or shares or other new securities of a similar nature which may be issued in respect of the shares or securities and all dividends and interest and all rights monies or property accruing or offered at any time by way of redemption bonus preference option or otherwise.
    Berechtigte Personen
    • Dukeminster Limited
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 21. Juni 1993
    Geliefert am 23. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1700000 ordinary shares in dwyer PLC including bonus stock or shares or other new securities and all dividends and interest.
    Berechtigte Personen
    • Dukeminster Limited
    Transaktionen
    • 23. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subordination
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 19. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from glenwing properties limited to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Al present and future liabilities of the borrower to the company whatsoever (whether principal or interest) (whether alone or jointly with any other person and in whatever style name or form and whether as principal or surety) (the junior debt) see 395 112/c 19/2 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge over joint venture agreement
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 12. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or glenwing properties limited pursuant to the terms of a facility agreement dated 29/1/93 the finance documents (as defined) and/or this charge
    Kurze Angaben
    First fixed legal charge all its present and future rights title and interest in the contract and sums which shall from time to time become payable to the chargor by mop or otherwise under the contract or any provision thereof please see 395 14/l 15/2 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanhai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party deed of charge over securities
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 12. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or glenwing properties limited pursuant to the terms of a facility agreement dated 29/1/93 the finance documents (as defined) and/or this charge
    Kurze Angaben
    Fixed legal charge to the chargee all of its present and future rights title and interest in and to all scheduled securities (as defined) as continuing security for the repayment of the indebtedness see 395 13/l 15/2 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of book debts
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 12. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or glenwing properties limited pursuant to the terms of a facility agreement dsated 29/1/93 the finanance documents (as defined) and/or this charge
    Kurze Angaben
    All its present and future rights title and interest inand to the loans made available to the borrower by the chargor under or pursuant to the terms of the joint venture agreement dated 23/11/87 please see 395 11/l 15/2 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hongkong and Shanhai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit account security terms
    Erstellt am 19. Nov. 1991
    Geliefert am 25. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee and indemnity dated 19TH november 1991
    Kurze Angaben
    £5O,ooo held in deposit account number 9OOOOO1 in the name of the company with the bank. See form 395 and continuation sheets relevant to this charge.
    Berechtigte Personen
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Aug. 1991
    Geliefert am 18. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents (as defined) and this charge
    Kurze Angaben
    All rights title and benefit of 10 fully paid "a" shares of £1 each in the share capital of high holburn estates limited (see form 395 and continuation sheets relevant to this charge).
    Berechtigte Personen
    • Mid U.K. Limited.
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subardination deed
    Erstellt am 07. Aug. 1990
    Geliefert am 24. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from winglow securities limited. To the chargee under the terms of the financing documents (as defined) and this charge.
    Kurze Angaben
    The lender undertakes to and for the benefit of the company, ryehire and the trustee that will not seek repayment or payment of any amount owed by the company or ryehire to the lender. (See 395 ref M53 and cont'd sheets for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trustee Company Limited (As Defined)in Its Capacity as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 07. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreement dated 11/7/88 and this charge
    Kurze Angaben
    The comapny charges all rights, title, interest and benefit present or future. (See 395 ref M10 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trustee Comapny Limited (As Defined)in Its Capacity as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    Security assignment
    Erstellt am 07. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financing documents (as defined) and this charge.
    Kurze Angaben
    The company as beneficial owner and as security for the liabilities hereby charges by way of first fixed charge and assigns absolutly to the aget all the benefits of the lease (see 395 ref: M9 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company Limited (As Defined)in Its Capacity as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    Deed of priority and subordination
    Erstellt am 02. Aug. 1989
    Geliefert am 22. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from twimac limited now known as high holborn estates limited at to the charge (in its capacity as trustee for the agent and the banks) as defined under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    In relation to payments made or amounts recevied or recovered see doc for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 13. Okt. 1987
    Geliefert am 20. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 13/10/87 and all other monies due or to become due or any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Aug. 1986
    Geliefert am 02. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First - l/hold - 24 uper brook street, london, westmisnter title no. Ln 155303 secondly - l/hold - 3RD & 4TH floors 24 upper brook street, westminster, london title no. Ln 138018 (for further details see doc M395). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    First legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 1986
    Geliefert am 29. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the avon mews limited to the chargee on any accont whatsoever.
    Kurze Angaben
    First fixed charge on f/h property 31,33, and 35 mawell street london E1 f/hold property 1 alie street london E1 see doc M98 for fuller details.
    Berechtigte Personen
    • N.M. Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    General security assignment
    Erstellt am 06. Feb. 1986
    Geliefert am 25. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the agreements, the general security assignment or any related security document as defined in the deed.
    Kurze Angaben
    1. the company as beneficial owner assigs absolutely a) all its rights title and interest in and to an agreemetn (the contract) dated 8-1-86 b) all sums payable under the contract. C) all rights - connection with any breach or default (see doc M96 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Edward Manson & Company Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Letter of set-off
    Erstellt am 07. Nov. 1984
    Geliefert am 14. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All or any part of any balance standing to the credit of any account in the name of the comapny with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Johnson Matthey Bankers Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 1984
    Geliefert am 20. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold 24 upper brook street city of westminster london please see doc M92 for full details of property charged. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    Secondary memorandum
    Erstellt am 01. Juli 1983
    Geliefert am 05. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or winglaw developments limited to the chargee on any account whatsover.
    Kurze Angaben
    23-25, hastfield rd., Wimbledon london SW9 title no. Sy 328166 sy 192938.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhatton Bank N.A.
    Transaktionen
    • 05. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    • 17. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 1982
    Geliefert am 03. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    51,53 and 55 fairfax road, camden, london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Manufactureers Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 1982
    Geliefert am 03. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehld property known as beverly court 5./61 (odd nos) fairfax road, st johns wood camden, london.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    General security agreement
    Erstellt am 01. Dez. 1982
    Geliefert am 03. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securign all monies due or to become due from the company to the chargee ender the terms of the facility agreement dated 30TH november 1982
    Kurze Angaben
    1) all of the owners right title & interest in and to the conract. 2) all sums which shall from time to time become payable to the ower by the purchaser. 3) all of the oners rights title interest in and to all monies 4) all of the owners right to title and interest in and to the borrower security and to the borrower security documents (see M88).
    Berechtigte Personen
    • Manufactureer Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 1982
    Geliefert am 03. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known ad denhamcourt, 63/71 (odd nos.) fairfax road, camden, london,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Manufacturer Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat CLAY GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Jan. 2008Beginn der Liquidation
    01. Juli 2010Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Andronikou
    Quadrant House 17 Thomas More Street
    Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praktiker
    Quadrant House 17 Thomas More Street
    Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0