KUK REALISATIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | KUK REALISATIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00592639 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KUK REALISATIONS LIMITED?
- (5190) /
Wo befindet sich KUK REALISATIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Deloitte Llp 1 City Square LS1 2AL Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KUK REALISATIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
KING UK LIMITED | 31. März 2000 | 31. März 2000 |
AUTOBAR LIMITED | 06. Juli 1990 | 06. Juli 1990 |
AUTOBAR FOOD SERVICES LIMITED | 06. Mai 1982 | 06. Mai 1982 |
AUTOBAR VENDING SUPPLIES LIMITED | 28. Okt. 1957 | 28. Okt. 1957 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KUK REALISATIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KUK REALISATIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 3 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2012 | 7 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2012 | 6 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2012 | 7 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Insolvenzmeldung Insolvency:- notice of common law disclaimer | 1 Seiten | LIQ MISC | ||
Insolvenzmeldung Insolvency:notice of common law disclaimer from treasury solicitors | 1 Seiten | LIQ MISC | ||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:Notice of common law disclaimer from Treasury Solicitors | 1 Seiten | LIQ MISC | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2011 | 6 Seiten | 4.68 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Jan. 2010 | 23 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 23 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Sept. 2009 | 24 Seiten | 2.24B | ||
Vorschlag des Verwalters | 65 Seiten | 2.17B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 67 Seiten | 2.23B | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed king uk LIMITED\certificate issued on 30/03/09 | 2 Seiten | CERTNM | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 19 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 8 Seiten | 363s |
Wer sind die Geschäftsführer von KUK REALISATIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARD, Peter John | Sekretär | The Hollies Hollies Lane SK9 2BW Wilmslow Cheshire | British | 12473890001 | ||||||
HIGSON, Martin Peter | Geschäftsführer | Oakwood House Nottingham Road LE67 8HN Peggs Green Leicestershire | England | British | Company Director | 48262920002 | ||||
SANDER, Christoph Paul | Geschäftsführer | 43 The Avenue KT20 5DB Tadworth Surrey | England | British | Business Manager | 35554030003 | ||||
WALLWORK, David Melvyn | Geschäftsführer | Windley Hall DE56 2LP Windley Derbyshire | United Kingdom | British | Business Manager | 76677450001 | ||||
WARD, Peter John | Geschäftsführer | The Hollies Hollies Lane SK9 2BW Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | Director | 12473890001 | ||||
ARMSTRONG, Stephen Derek | Sekretär | Main Street Kirklington NG22 8NN Nr Newark Hall Farm Nottinghamshire Uk | British | Director | 180767850001 | |||||
BLACKWELL, John David | Sekretär | 3 Highfields Park Drive Broadway DE22 1BW Derby Derbyshire | British | Accountant | 118151930001 | |||||
GREENWOOD, Michael Frank | Sekretär | Gloucester Road Kew TW9 3BT Richmond 51 Surrey | British | Director | 90910000002 | |||||
MCKAY, William Trevor | Sekretär | 1 West Court HA0 3QQ North Wembley Middlesex | British | 588890001 | ||||||
MCKAY, William Trevor | Sekretär | 1 West Court HA0 3QQ North Wembley Middlesex | British | 588890001 | ||||||
BLACKWELL, John David | Geschäftsführer | 3 Highfields Park Drive Broadway DE22 1BW Derby Derbyshire | United Kingdom | British | Accountant | 118151930001 | ||||
BRISTOW, Andrew Wyatt | Geschäftsführer | Garden Road BR1 3LX Bromley 22 Kent | England | British | Company Director | 8748280008 | ||||
BRISTOW, Andrew Wyatt | Geschäftsführer | 29 Albyfield BR1 2HY Bickley Kent | British | Company Director | 8748280003 | |||||
CALTHORPE, Malcolm Richard | Geschäftsführer | 6 Littlewood HP14 3TF Stokenchurch Buckinghamshire | British | Company Director | 61833460001 | |||||
CHAPMAN, Philip John | Geschäftsführer | Spinnaker Horsell Park GU21 4LY Woking Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 25169060001 | ||||
DAVEY, Michael John | Geschäftsführer | 225 Sheen Lane East Sheen SW14 8LE London | United Kingdom | British | Company Director | 976330001 | ||||
EDWARDS, Kenneth | Geschäftsführer | 37 Meadow Road HA5 1EB Pinner Middlesex | England | British | Director | 78659030001 | ||||
FOSTER, John | Geschäftsführer | 21 Wood End Drive SL5 9BD South Ascot Berkshire | British | Company Director | 44042620001 | |||||
HALL, Jane | Geschäftsführer | 90 Lowther Road LU6 3LQ Dunstable Bedfordshire | British | Company Director | 92361200001 | |||||
HOBBS, David Dudley | Geschäftsführer | 15 Greenside Edgcumbe Park RG45 6EX Crowthorne Berkshire | British | Company Director | 37745610001 | |||||
JOHNS, Ian Francis | Geschäftsführer | 3 Mistletoe Close Shirley Oaks CR0 8YE Croydon Surrey | United Kingdom | British | Commercial Director | 112454960001 | ||||
JONES, Anthony Glyn | Geschäftsführer | 7 Croft Avenue Simister Prestwich M25 2SE Manchester Greater Manchester | British | Operations Director | 52257940001 | |||||
KELLY, David Patrick | Geschäftsführer | The Cedars 69 Grove Park WA16 8QE Knutsford Cheshire | England | British | Company Director | 90542630001 | ||||
KIRWIN, Daniel Mark | Geschäftsführer | 22 The Dairyground Shutford OX15 6PN Banbury | United Kingdom | English | Director | 100497280001 | ||||
MACLEOD, Neil Shaw | Geschäftsführer | 18 Millfield HP4 2PB Berkhamsted Hertfordshire | British | Accountant | 72676970002 | |||||
MCAULAY, Alan | Geschäftsführer | 92 Hatfield Gardens WA4 5QJ Appleton Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 133843600001 | ||||
MCAULAY, Alan | Geschäftsführer | 17 Valence Crescent OX8 5GD Witney Oxfordshire | British | Director | 43139440001 | |||||
MOULDS, Adrian Paul | Geschäftsführer | Ferris House Newbarn Lane HP9 2QZ Seer Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 161093650001 | ||||
O'LEARY, Mark Joseph Christopher | Geschäftsführer | 14 Meadow View SL7 3PA Marlow Bottom Buckinghamshire | Irish | Group Finance Director | 43800040002 | |||||
PASCAL, Francis Marie Andre | Geschäftsführer | 5 Rue Nobel FOREIGN Paris 75018 France | French | Director | 88355830001 | |||||
PRENDERGAST, Patrick Charles | Geschäftsführer | 1 Erpingham Court Sea Lane PE36 6JX Old Hunstanton Norfolk | British | Company Director | 25169050003 | |||||
PRENDERGAST, Patrick Charles | Geschäftsführer | Rosewood Shootersway Lane HP4 3NW Berkhamsted Hertfordshire | British | Company Director | 25169050002 | |||||
PRICE, Stephen | Geschäftsführer | 85 Station Road Stoke Mandeville HP22 5UA Aylesbury Buckinghamshire | British | Finance Director | 58110920001 | |||||
REVELL, Michael John | Geschäftsführer | Tinkers Broad Street Cuckfield RH17 5DX Haywards Heath West Sussex | British | Director | 110714140001 | |||||
ROE, Timothy Michael | Geschäftsführer | Kenley Road SW19 3JQ London 2a | England | British | Director | 51264250001 |
Hat KUK REALISATIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 05. Jan. 2007 Geliefert am 16. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 20. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 13/08/04 and | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 20. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any lender or subordinated lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects known as and forming 30 to 36 napier place wardpark north cumbernauld t/no DMB35760 together with the whole buildings and other erections the fittings and fixtures. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 13/08/04 and | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 20. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any lender or subordinated lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects lying on the east side of mary street glasgow and high craighall street glasgow t/no GLA137484 together with the whole buildings and other erections fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession to a debenture dated 2 july 2004 | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 10. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to a) the real property b) the tangible moveable property c) the accounts d) the intellectual property e) any goodwill. Assigns a) the proceeds of any insurance policy and all related rights b) all rights and claims in relation to any assigned account. By way of floating charge the assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 05. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Unit 2 euroway estate denby way hellaby rotherham t/no SYK276571, 512 wallisdown road bourenmouth t/no DT65517, unit A1 swift park old leicester road rugby t/no WK346149 and land at pit hey place skelmersdale lancashire t/no LA871988 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus letter of set-off | Erstellt am 31. März 1987 Geliefert am 14. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Inter company letter of set off | Erstellt am 01. Aug. 1983 Geliefert am 18. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat KUK REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0