KUK REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKUK REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00592639
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KUK REALISATIONS LIMITED?

    • (5190) /

    Wo befindet sich KUK REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KUK REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KING UK LIMITED31. März 200031. März 2000
    AUTOBAR LIMITED06. Juli 199006. Juli 1990
    AUTOBAR FOOD SERVICES LIMITED06. Mai 198206. Mai 1982
    AUTOBAR VENDING SUPPLIES LIMITED28. Okt. 195728. Okt. 1957

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KUK REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für KUK REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72
    A28Y481K

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2012

    7 Seiten4.68
    A1HUK7AA

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2012

    6 Seiten4.68
    A1HUK7AQ

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2012

    7 Seiten4.68
    A14NVYMB

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Aug. 2011

    5 Seiten4.68
    AAEBEXJ3

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:- notice of common law disclaimer
    1 SeitenLIQ MISC
    AO4ATWGH

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:notice of common law disclaimer from treasury solicitors
    1 SeitenLIQ MISC
    AYHCKW5M

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Notice of common law disclaimer from Treasury Solicitors
    1 SeitenLIQ MISC
    AYJ7MVL0

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2011

    6 Seiten4.68
    AUV51SDA

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Jan. 2010

    23 Seiten2.24B
    A4DQ3HNO

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    23 Seiten2.34B
    A4DQ4HNP

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Sept. 2009

    24 Seiten2.24B
    AM9NUE66

    Vorschlag des Verwalters

    65 Seiten2.17B
    CXRILAMZ

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    67 Seiten2.23B
    PFXQGA2J

    legacy

    1 Seiten287
    AFPLE8CX

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed king uk LIMITED\certificate issued on 30/03/09
    2 SeitenCERTNM
    ACXLV8IP

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B
    AFPLC8CV

    legacy

    4 Seiten363a
    XS4S1YO8

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    8 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von KUK REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WARD, Peter John
    The Hollies
    Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    The Hollies
    Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    British12473890001
    HIGSON, Martin Peter
    Oakwood House
    Nottingham Road
    LE67 8HN Peggs Green
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Oakwood House
    Nottingham Road
    LE67 8HN Peggs Green
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director48262920002
    SANDER, Christoph Paul
    43 The Avenue
    KT20 5DB Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    43 The Avenue
    KT20 5DB Tadworth
    Surrey
    EnglandBritishBusiness Manager35554030003
    WALLWORK, David Melvyn
    Windley Hall
    DE56 2LP Windley
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Windley Hall
    DE56 2LP Windley
    Derbyshire
    United KingdomBritishBusiness Manager76677450001
    WARD, Peter John
    The Hollies
    Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector12473890001
    ARMSTRONG, Stephen Derek
    Main Street
    Kirklington
    NG22 8NN Nr Newark
    Hall Farm
    Nottinghamshire
    Uk
    Sekretär
    Main Street
    Kirklington
    NG22 8NN Nr Newark
    Hall Farm
    Nottinghamshire
    Uk
    BritishDirector180767850001
    BLACKWELL, John David
    3 Highfields Park Drive
    Broadway
    DE22 1BW Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    3 Highfields Park Drive
    Broadway
    DE22 1BW Derby
    Derbyshire
    BritishAccountant118151930001
    GREENWOOD, Michael Frank
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    Sekretär
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    BritishDirector90910000002
    MCKAY, William Trevor
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    British588890001
    MCKAY, William Trevor
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    British588890001
    BLACKWELL, John David
    3 Highfields Park Drive
    Broadway
    DE22 1BW Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    3 Highfields Park Drive
    Broadway
    DE22 1BW Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritishAccountant118151930001
    BRISTOW, Andrew Wyatt
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    Geschäftsführer
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    EnglandBritishCompany Director8748280008
    BRISTOW, Andrew Wyatt
    29 Albyfield
    BR1 2HY Bickley
    Kent
    Geschäftsführer
    29 Albyfield
    BR1 2HY Bickley
    Kent
    BritishCompany Director8748280003
    CALTHORPE, Malcolm Richard
    6 Littlewood
    HP14 3TF Stokenchurch
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    6 Littlewood
    HP14 3TF Stokenchurch
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director61833460001
    CHAPMAN, Philip John
    Spinnaker Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Spinnaker Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director25169060001
    DAVEY, Michael John
    225 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    Geschäftsführer
    225 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    United KingdomBritishCompany Director976330001
    EDWARDS, Kenneth
    37 Meadow Road
    HA5 1EB Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    37 Meadow Road
    HA5 1EB Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishDirector78659030001
    FOSTER, John
    21 Wood End Drive
    SL5 9BD South Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    21 Wood End Drive
    SL5 9BD South Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director44042620001
    HALL, Jane
    90 Lowther Road
    LU6 3LQ Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    90 Lowther Road
    LU6 3LQ Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director92361200001
    HOBBS, David Dudley
    15 Greenside
    Edgcumbe Park
    RG45 6EX Crowthorne
    Berkshire
    Geschäftsführer
    15 Greenside
    Edgcumbe Park
    RG45 6EX Crowthorne
    Berkshire
    BritishCompany Director37745610001
    JOHNS, Ian Francis
    3 Mistletoe Close
    Shirley Oaks
    CR0 8YE Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Mistletoe Close
    Shirley Oaks
    CR0 8YE Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishCommercial Director112454960001
    JONES, Anthony Glyn
    7 Croft Avenue Simister
    Prestwich
    M25 2SE Manchester
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    7 Croft Avenue Simister
    Prestwich
    M25 2SE Manchester
    Greater Manchester
    BritishOperations Director52257940001
    KELLY, David Patrick
    The Cedars
    69 Grove Park
    WA16 8QE Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Cedars
    69 Grove Park
    WA16 8QE Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director90542630001
    KIRWIN, Daniel Mark
    22 The Dairyground
    Shutford
    OX15 6PN Banbury
    Geschäftsführer
    22 The Dairyground
    Shutford
    OX15 6PN Banbury
    United KingdomEnglishDirector100497280001
    MACLEOD, Neil Shaw
    18 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    18 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishAccountant72676970002
    MCAULAY, Alan
    92 Hatfield Gardens
    WA4 5QJ Appleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    92 Hatfield Gardens
    WA4 5QJ Appleton
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director133843600001
    MCAULAY, Alan
    17 Valence Crescent
    OX8 5GD Witney
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    17 Valence Crescent
    OX8 5GD Witney
    Oxfordshire
    BritishDirector43139440001
    MOULDS, Adrian Paul
    Ferris House
    Newbarn Lane
    HP9 2QZ Seer Green
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Ferris House
    Newbarn Lane
    HP9 2QZ Seer Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director161093650001
    O'LEARY, Mark Joseph Christopher
    14 Meadow View
    SL7 3PA Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    14 Meadow View
    SL7 3PA Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    IrishGroup Finance Director43800040002
    PASCAL, Francis Marie Andre
    5 Rue Nobel
    FOREIGN Paris 75018
    France
    Geschäftsführer
    5 Rue Nobel
    FOREIGN Paris 75018
    France
    FrenchDirector88355830001
    PRENDERGAST, Patrick Charles
    1 Erpingham Court
    Sea Lane
    PE36 6JX Old Hunstanton
    Norfolk
    Geschäftsführer
    1 Erpingham Court
    Sea Lane
    PE36 6JX Old Hunstanton
    Norfolk
    BritishCompany Director25169050003
    PRENDERGAST, Patrick Charles
    Rosewood
    Shootersway Lane
    HP4 3NW Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Rosewood
    Shootersway Lane
    HP4 3NW Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director25169050002
    PRICE, Stephen
    85 Station Road
    Stoke Mandeville
    HP22 5UA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    85 Station Road
    Stoke Mandeville
    HP22 5UA Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director58110920001
    REVELL, Michael John
    Tinkers
    Broad Street Cuckfield
    RH17 5DX Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tinkers
    Broad Street Cuckfield
    RH17 5DX Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector110714140001
    ROE, Timothy Michael
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    Geschäftsführer
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    EnglandBritishDirector51264250001

    Hat KUK REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 05. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland Trading as Enterprise Finance Europe
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession
    Erstellt am 12. Dez. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas as Security Agent
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 13/08/04 and
    Erstellt am 02. Aug. 2004
    Geliefert am 20. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any lender or subordinated lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as and forming 30 to 36 napier place wardpark north cumbernauld t/no DMB35760 together with the whole buildings and other erections the fittings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 13/08/04 and
    Erstellt am 02. Aug. 2004
    Geliefert am 20. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any lender or subordinated lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects lying on the east side of mary street glasgow and high craighall street glasgow t/no GLA137484 together with the whole buildings and other erections fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession to a debenture dated 2 july 2004
    Erstellt am 02. Aug. 2004
    Geliefert am 10. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to a) the real property b) the tangible moveable property c) the accounts d) the intellectual property e) any goodwill. Assigns a) the proceeds of any insurance policy and all related rights b) all rights and claims in relation to any assigned account. By way of floating charge the assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Aug. 2004
    Geliefert am 05. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 2 euroway estate denby way hellaby rotherham t/no SYK276571, 512 wallisdown road bourenmouth t/no DT65517, unit A1 swift park old leicester road rugby t/no WK346149 and land at pit hey place skelmersdale lancashire t/no LA871988 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Omnibus letter of set-off
    Erstellt am 31. März 1987
    Geliefert am 14. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Inter company letter of set off
    Erstellt am 01. Aug. 1983
    Geliefert am 18. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1983Registrierung einer Belastung

    Hat KUK REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. März 2009Beginn der Verwaltung
    22. Feb. 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Kenneth Dawson
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    22. Feb. 2010Beginn der Liquidation
    29. Aug. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0