THE TAMARISK TRUST

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE TAMARISK TRUST
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 00595338
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE TAMARISK TRUST?

    • Soziale Arbeit ohne Unterbringung für ältere und behinderte Menschen (88100) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich THE TAMARISK TRUST?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o HFT
    5/6 Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE TAMARISK TRUST?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE TAMARISK TRUST HOMES FOR THE MENTALLY HANDICAPPED02. Nov. 198902. Nov. 1989
    RETARDED CHILDREN'S AID SOCIETY 31. Dez. 197631. Dez. 1976

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE TAMARISK TRUST?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für THE TAMARISK TRUST?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE TAMARISK TRUST?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2015 ohne Mitgliederliste

    AR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark Christopher Morris als Geschäftsführer am 27. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Janice Patricia Bracey als Geschäftsführer am 27. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2014 ohne Mitgliederliste

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    10 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 1a 1St Floor, the Old Print Works 25 Tapster Street, High Barnet Hertfordshire EN5 5TH* am 16. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2013 ohne Mitgliederliste

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2012 ohne Mitgliederliste

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Jeremy Doggett am 01. Jan. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    19 SeitenAA

    Ernennung von Miss Janice Patricia Bracey als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Apr. 2011 ohne Mitgliederliste

    2 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Alison Gent als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Waite als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Graham Stacy als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Margaret Litchfield als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Buckland als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Janice Bracey als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Neeta Bakrania als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von THE TAMARISK TRUST?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOGGETT, Nigel Jeremy
    c/o Hft
    Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    5/6
    Bristol
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hft
    Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    5/6
    Bristol
    England
    United KingdomBritish144535400004
    BAKRANIA, Neeta
    95 Brent Way
    Finchley
    N3 1AR London
    Sekretär
    95 Brent Way
    Finchley
    N3 1AR London
    British48622650002
    EVANS, Donald
    83 Randall Avenue
    NW2 7SX London
    Sekretär
    83 Randall Avenue
    NW2 7SX London
    British7311410001
    GREANY, Marion
    21 South Close
    EN5 5TP Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    21 South Close
    EN5 5TP Barnet
    Hertfordshire
    British27993030002
    HANNAFORD, Anne
    8 Byron Court
    EN2 8ER Enfield
    Middlesex
    Sekretär
    8 Byron Court
    EN2 8ER Enfield
    Middlesex
    British11574430001
    BOSWELL, Stephen Eric Roy
    53 Cromer Road
    New Barnet
    EN5 5HT Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    53 Cromer Road
    New Barnet
    EN5 5HT Barnet
    Hertfordshire
    British11574450001
    BRACEY, Janice Patricia
    c/o Hft
    Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    5/6
    Bristol
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hft
    Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    5/6
    Bristol
    England
    EnglandBritish153019960001
    BRACEY, Janice Patricia
    Queens Road
    SG13 8BJ Hertford
    85
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Queens Road
    SG13 8BJ Hertford
    85
    United Kingdom
    EnglandBritish153019960001
    BUCKLAND, Nicholas Simon
    32 Heath Drive
    EN6 1EH Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    32 Heath Drive
    EN6 1EH Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish18622570001
    CRANSTON, Suzanne Mary
    20 The Crest
    CM21 0ER Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    20 The Crest
    CM21 0ER Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British62426780001
    CROSTON, Diane
    85 Queens Road
    SG13 8BJ Hertford
    Geschäftsführer
    85 Queens Road
    SG13 8BJ Hertford
    British48732980002
    DANT, Christopher James
    Cheveley Park Stud
    Cheveley Park Stud, Cheveley
    CB8 9DD Newmarket
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Cheveley Park Stud
    Cheveley Park Stud, Cheveley
    CB8 9DD Newmarket
    Suffolk
    United KingdomBritish90654410002
    EKEMEZUMA, Patricia Naomi
    10 Belvedere Road
    Edmonton
    N9 9YT London
    Geschäftsführer
    10 Belvedere Road
    Edmonton
    N9 9YT London
    EnglandBritish94377490003
    EVANS, Donald
    83 Randall Avenue
    NW2 7SX London
    Geschäftsführer
    83 Randall Avenue
    NW2 7SX London
    British7311410001
    FAHERTY, Brenda
    Flat 29, The Panoramic
    12 Pond Street
    NW3 2PS London
    Geschäftsführer
    Flat 29, The Panoramic
    12 Pond Street
    NW3 2PS London
    United KingdomBritish5479600002
    GALE, Roger
    1 Oxford Court
    EN5 5EF Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Oxford Court
    EN5 5EF Barnet
    Hertfordshire
    British11574480001
    GENT, Alison Elizabeth, Jennifer, Dr
    1st Floor,
    The Old Print Works
    EN5 5TH 25 Tapster Street, High Barnet
    Unit 1a
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1st Floor,
    The Old Print Works
    EN5 5TH 25 Tapster Street, High Barnet
    Unit 1a
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147628350001
    GOODMAN, Cyril Benjamin
    7 Barchester Lodge
    92-94 Holden Road
    N12 7DY London
    Geschäftsführer
    7 Barchester Lodge
    92-94 Holden Road
    N12 7DY London
    United KingdomBritish18752000001
    GREANY, Marion
    21 South Close
    EN5 5TP Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    21 South Close
    EN5 5TP Barnet
    Hertfordshire
    British27993030002
    LITCHFIELD, Margaret
    1st Floor,
    The Old Print Works
    EN5 5TH 25 Tapster Street, High Barnet
    Unit 1a
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1st Floor,
    The Old Print Works
    EN5 5TH 25 Tapster Street, High Barnet
    Unit 1a
    Hertfordshire
    EnglandBritish117324560001
    MAINI, Kunj
    8 Milton Avenue
    EN5 2EX Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Milton Avenue
    EN5 2EX Barnet
    Hertfordshire
    British11574460001
    MCMAHON, Nona Patricia
    28b Ravenscroft Park
    EN5 4NH Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    28b Ravenscroft Park
    EN5 4NH Barnet
    Hertfordshire
    British48733010001
    MORRIS, Mark Christopher
    c/o Hft
    Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    5/6
    Bristol
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hft
    Brook Office Park
    Folly Brook Road
    BS16 7FL Emersons Green
    5/6
    Bristol
    England
    EnglandBritish147628740001
    SPENDIFF, Colin
    21 Shaftesbury Avenue
    New Barnet
    EN5 5JA Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    21 Shaftesbury Avenue
    New Barnet
    EN5 5JA Barnet
    Hertfordshire
    British39247000001
    STACY, Graham Henry
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    Geschäftsführer
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    United KingdomBritish45227350001
    WAITE, John Maxwell
    1st Floor,
    The Old Print Works
    EN5 5TH 25 Tapster Street, High Barnet
    Unit 1a
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1st Floor,
    The Old Print Works
    EN5 5TH 25 Tapster Street, High Barnet
    Unit 1a
    Hertfordshire
    United KingdomBritish39333440001
    WATTS, Kathleen
    40 Ryecroft Crescent
    EN5 3BU Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    40 Ryecroft Crescent
    EN5 3BU Barnet
    Hertfordshire
    British11574440001
    WEST, George
    4 Warwick Road
    New Barnet
    EN5 5ED Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Warwick Road
    New Barnet
    EN5 5ED Barnet
    Hertfordshire
    British11574470001

    Hat THE TAMARISK TRUST Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 26. März 2010
    Geliefert am 01. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 109 (part) 111 and 113 leicester road barnet t/nos NGL357233 NGL214946 and NGL110603 and part of the land comprised in t/no NGL121753; and all buildings fixtures and fixed plant and machinery, benefit of all contracts and warranties. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sanctuary Housing Association
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 warwick road new barnet herts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 2006
    Geliefert am 12. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H properties at 102, 111 and 113 leicester road new barnet herts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 2004
    Geliefert am 28. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    111 and 113 leicester road new barnet hertfordshire t/ns NGL214946 and NGL357233 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. März 1994
    Geliefert am 23. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 warwick road, new barnet, hertfordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. März 1994
    Geliefert am 23. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H properties k/a 102, 111 and 113 leicester road, barnet, greater london t/nos. NGL14757, NGL214946 and NGL357233 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Dez. 1993
    Geliefert am 15. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1 oxford court, warwick road, l/b of barnet t/no. NGL251551 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Dez. 1993
    Geliefert am 15. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 4 oxford court, warwick road, l/b of barnet t/no. NGL259209 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. März 1992
    Geliefert am 10. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    102 leicester road new barnet,london t/n NGL14757 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juni 1991
    Geliefert am 17. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    111 leicester road new barnet herts l/b of barnet t/n NGL214946 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 15. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juni 1991
    Geliefert am 17. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    113 leicester road new barnet herts l/b of barnet t/n NGL357233 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 15. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Apr. 1989
    Geliefert am 21. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 warwick road new barnet and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1979
    Geliefert am 12. Feb. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    At any time placed upon or used in or about the property viz:- f/h property known as 2 warwick road, new barnet herts.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1979Registrierung einer Belastung
    • 14. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1979
    Geliefert am 12. Feb. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    At any time placed upon or used in or about the property viz:- 4 oxford court, warwick road, new barnet. Herts. Title no. Ngl 259209.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1979Registrierung einer Belastung
    • 14. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Sept. 1969
    Geliefert am 19. Sept. 1969
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £5000 and further advances
    Kurze Angaben
    117, clapton common, hackney, E.8.
    Berechtigte Personen
    • The Halifax Building Society
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1969Registrierung einer Belastung
    • 14. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. März 1962
    Geliefert am 03. Apr. 1962
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc.
    Kurze Angaben
    104 leicester road, new barnet, herts.
    Berechtigte Personen
    • Westminster Bank LTD
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1962Registrierung einer Belastung
    • 14. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0