EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED

EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00595835
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 005958350023 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 005958350022 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Angus Alexander Dodd als Geschäftsführer am 07. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2019 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    15 SeitenAA

    Change of details for Estates Property Investment Company Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2017

    2 SeitenPSC05

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Angus Alexander Dodd am 01. Dez. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Frances Victoria Heazell am 01. Dez. 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Michael Ben Jenkins am 01. Dez. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Rajesh Shah am 01. Dez. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr. James Michael Edward Saunders am 01. Dez. 2017

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 43-45 Portman Square London W1H 6LY zum 180 Great Portland Street London W1W 5QZ am 03. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Eintragung der Belastung 005958350023, erstellt am 03. Nov. 2017

    134 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    16 SeitenAA

    Ernennung von Mr Michael Ben Jenkins als Direktor am 13. Jan. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Geoffrey Carter als Geschäftsführer am 13. Jan. 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875650001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SHAH, Rajesh
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish150630770001
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish267205160001
    COOK, Anthony
    Flat 81 Darwin Court
    2-24 Gloucester Avenue
    NW1 7BQ London
    Sekretär
    Flat 81 Darwin Court
    2-24 Gloucester Avenue
    NW1 7BQ London
    British8492960001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Sekretär
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Sekretär
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Sekretär
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104140001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Sekretär
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Sekretär
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Sekretär
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Geschäftsführer
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Geschäftsführer
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Geschäftsführer
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GILL, Anthony Douglas
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish178214790001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Geschäftsführer
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    JONES, Christopher Neville
    55 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    55 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    EnglandBritish109266700001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Geschäftsführer
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    STRINGER, Reginald
    Pipers Landing
    Green Lane Albury
    GU5 9EP Guildford
    Geschäftsführer
    Pipers Landing
    Green Lane Albury
    GU5 9EP Guildford
    British11500100002
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WINGATE, Stephan Anthony
    58 Pont Street
    SW1X 0AE London
    Geschäftsführer
    58 Pont Street
    SW1X 0AE London
    United KingdomBritish33528820002
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish42858810002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUnited Kingdom
    Registrierungsnummer666487
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2017
    Geliefert am 09. Nov. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Homes and Communities Agency
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Jan. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2016
    Geliefert am 15. Nov. 2016
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Jan. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge and release
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 08. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates proerty investment company limited and all other monies secured by the deed and trust deed dated 28TH april 1986 (the principal deed) and all deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    The capital sum of £7,880,000.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge and release
    Erstellt am 25. Juni 2001
    Geliefert am 29. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and the deeds supplemental thereto of various dates
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a centre heights 135-151 finchley road london NW3 t/n NGL716912 and adjacent land forming part of the frontage to belsize road t/n NGL459004, assigned all moneys payable by virtue of any insurances on the new property.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 29. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Apr. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge and release
    Erstellt am 16. Jan. 2001
    Geliefert am 22. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28TH april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates
    Kurze Angaben
    The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as defined in the principal deed). The leasehold property at 2/10 trinity street, coventry CV1 1FL. Title number WM692715.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenant
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 (the "stock") of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the hereinbefore described deed of covenant dated 31 march 2000 and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates
    Kurze Angaben
    The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as descrobed in the principal deed) including (without prejudice to the generality of the foregoing) insurance effected pursuant to clauses 16(m) & 16(n)(subject as thereby provided) of the principal deed. The f/h land and buildings on the north-west side of broad green road,lakeside industrial estate,redditch,hereford and worcester.t/no.HW162933.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 15. Apr. 1993
    Geliefert am 27. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & lucas office enviroments (scotland) limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 15. Apr. 1993
    Geliefert am 27. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emaco limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 15. Apr. 1993
    Geliefert am 27. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emstar limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 15. Apr. 1993
    Geliefert am 27. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & C.A. industrial finance limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 15. Apr. 1993
    Geliefert am 27. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & james clark. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 15. Apr. 1993
    Geliefert am 27. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys rights to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & kavo dental limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 24. März 1993
    Geliefert am 05. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter & overdraft facility letter dated 24/3/93 (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    The benefit of the rents licence fees tenancies or licences in f/h property k/a units 5 & 6 athena ave, elgin drive industrial est, swindon t/no WT6 4045 & f/a property k/a blocks g s & m the james est, mitcham t/no sy 278922.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 1998Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 24. März 1993
    Geliefert am 30. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at kembry street and elgin drive k/a units 5 and 6 elgin drive ind: est: swindon wiltshire tog: with all buildings and fixtures and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 1998Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 24. März 1993
    Geliefert am 30. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on south east of bond road k/a blocks g,s & m,the james estate tog: with all buildings and fixtures, goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security regdin scotland
    Erstellt am 02. Aug. 1990
    Geliefert am 10. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to become due from the development and realisation trust limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Epic house, 28/32 cadogan street, glasgow.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and charge
    Erstellt am 17. März 1989
    Geliefert am 04. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys due to the charge secured by the trust deed dated 28TH april 1986 as ameaded and supplemented.
    Kurze Angaben
    F/H property at camberwell in london borough of southwark having a frontage to daneville road orpwells street denmark hill and wrean road t/n sgl 444643.together with all buildings, erections and fittings fixtures fixed plant as machinery.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security reg in scotland 24.10.86.
    Erstellt am 04. Nov. 1986
    Geliefert am 05. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    28/32 cadogan street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • National Provident Institution
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Trust deed
    Erstellt am 28. Apr. 1986
    Geliefert am 30. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all of her monies intended to be secured by the said trust deed
    Kurze Angaben
    L/Hold land k/as 110 euston road, londont/n ngl 148020 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. For full details see doc M68.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Letter
    Erstellt am 18. Apr. 1986
    Geliefert am 02. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £780,000 all monies due or to become due fro the company under the terms of the principal mortgage dated 21.5.71
    Kurze Angaben
    Cash sum of sterling pound 780,000 deposited with charge.
    Berechtigte Personen
    • National Provident Institution
    Transaktionen
    • 02. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    Supplemental trust deed
    Erstellt am 22. Sept. 1977
    Geliefert am 06. Okt. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For futher securing debentures stock of estates property investment company amounting to £1700000 securies by a trust deed dated 4/9/63
    Kurze Angaben
    Central buildings brook st wrexham comprised in a conveyance dated 26/3/64.
    Berechtigte Personen
    • Phoenix Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1977Registrierung einer Belastung
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust deed
    Erstellt am 04. Sept. 1963
    Geliefert am 04. Sept. 1963
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    1.700.000 debenture stock of estates property investment company LTD
    Kurze Angaben
    Various properties in kent, london staffs, sheffield and bristol (for details see doc. 29).
    Berechtigte Personen
    • Phoenix Assurance Company LTD
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1963Registrierung einer Belastung
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0