EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00595835 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Erfüllung der Belastung 005958350023 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 005958350022 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Angus Alexander Dodd als Geschäftsführer am 07. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 15 Seiten | AA | ||
Change of details for Estates Property Investment Company Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr. Angus Alexander Dodd am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Frances Victoria Heazell am 01. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr. Michael Ben Jenkins am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Rajesh Shah am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr. James Michael Edward Saunders am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 43-45 Portman Square London W1H 6LY zum 180 Great Portland Street London W1W 5QZ am 03. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Eintragung der Belastung 005958350023, erstellt am 03. Nov. 2017 | 134 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Michael Ben Jenkins als Direktor am 13. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Geoffrey Carter als Geschäftsführer am 13. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875650001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SHAH, Rajesh | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 150630770001 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 267205160001 | |||||
| COOK, Anthony | Sekretär | Flat 81 Darwin Court 2-24 Gloucester Avenue NW1 7BQ London | British | 8492960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Sekretär | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Sekretär | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Sekretär | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Sekretär | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104140001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Sekretär | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Sekretär | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Sekretär | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Sekretär | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Geschäftsführer | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Geschäftsführer | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Geschäftsführer | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Geschäftsführer | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GILL, Anthony Douglas | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 178214790001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Geschäftsführer | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| JONES, Christopher Neville | Geschäftsführer | 55 York Mews GU34 1JD Alton Hampshire | England | British | 109266700001 | |||||
| RILEY, Michael Edward | Geschäftsführer | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Geschäftsführer | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| STRINGER, Reginald | Geschäftsführer | Pipers Landing Green Lane Albury GU5 9EP Guildford | British | 11500100002 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Geschäftsführer | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WINGATE, Stephan Anthony | Geschäftsführer | 58 Pont Street SW1X 0AE London | United Kingdom | British | 33528820002 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Geschäftsführer | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Geschäftsführer | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estates Property Investment Company Limited | 06. Apr. 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2017 Geliefert am 09. Nov. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 15. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and release | Erstellt am 01. Feb. 2002 Geliefert am 08. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates proerty investment company limited and all other monies secured by the deed and trust deed dated 28TH april 1986 (the principal deed) and all deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben The capital sum of £7,880,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and release | Erstellt am 25. Juni 2001 Geliefert am 29. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and the deeds supplemental thereto of various dates | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a centre heights 135-151 finchley road london NW3 t/n NGL716912 and adjacent land forming part of the frontage to belsize road t/n NGL459004, assigned all moneys payable by virtue of any insurances on the new property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and release | Erstellt am 16. Jan. 2001 Geliefert am 22. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28TH april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates | |
Kurze Angaben The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as defined in the principal deed). The leasehold property at 2/10 trinity street, coventry CV1 1FL. Title number WM692715. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 14. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 (the "stock") of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the hereinbefore described deed of covenant dated 31 march 2000 and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates | |
Kurze Angaben The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as descrobed in the principal deed) including (without prejudice to the generality of the foregoing) insurance effected pursuant to clauses 16(m) & 16(n)(subject as thereby provided) of the principal deed. The f/h land and buildings on the north-west side of broad green road,lakeside industrial estate,redditch,hereford and worcester.t/no.HW162933. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & lucas office enviroments (scotland) limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emaco limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emstar limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & C.A. industrial finance limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & james clark. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rental income | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys rights to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & kavo dental limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 24. März 1993 Geliefert am 05. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter & overdraft facility letter dated 24/3/93 (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben The benefit of the rents licence fees tenancies or licences in f/h property k/a units 5 & 6 athena ave, elgin drive industrial est, swindon t/no WT6 4045 & f/a property k/a blocks g s & m the james est, mitcham t/no sy 278922. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. März 1993 Geliefert am 30. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at kembry street and elgin drive k/a units 5 and 6 elgin drive ind: est: swindon wiltshire tog: with all buildings and fixtures and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. März 1993 Geliefert am 30. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on south east of bond road k/a blocks g,s & m,the james estate tog: with all buildings and fixtures, goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security regdin scotland | Erstellt am 02. Aug. 1990 Geliefert am 10. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing all monies due or to become due from the development and realisation trust limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Epic house, 28/32 cadogan street, glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and charge | Erstellt am 17. März 1989 Geliefert am 04. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys due to the charge secured by the trust deed dated 28TH april 1986 as ameaded and supplemented. | |
Kurze Angaben F/H property at camberwell in london borough of southwark having a frontage to daneville road orpwells street denmark hill and wrean road t/n sgl 444643.together with all buildings, erections and fittings fixtures fixed plant as machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security reg in scotland 24.10.86. | Erstellt am 04. Nov. 1986 Geliefert am 05. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 28/32 cadogan street glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 28. Apr. 1986 Geliefert am 30. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all of her monies intended to be secured by the said trust deed | |
Kurze Angaben L/Hold land k/as 110 euston road, londont/n ngl 148020 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. For full details see doc M68. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter | Erstellt am 18. Apr. 1986 Geliefert am 02. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £780,000 all monies due or to become due fro the company under the terms of the principal mortgage dated 21.5.71 | |
Kurze Angaben Cash sum of sterling pound 780,000 deposited with charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 22. Sept. 1977 Geliefert am 06. Okt. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For futher securing debentures stock of estates property investment company amounting to £1700000 securies by a trust deed dated 4/9/63 | |
Kurze Angaben Central buildings brook st wrexham comprised in a conveyance dated 26/3/64. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 04. Sept. 1963 Geliefert am 04. Sept. 1963 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 1.700.000 debenture stock of estates property investment company LTD | |
Kurze Angaben Various properties in kent, london staffs, sheffield and bristol (for details see doc. 29). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0