ENVOPAK GROUP
Überblick
| Unternehmensname | ENVOPAK GROUP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 00596706 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENVOPAK GROUP?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ENVOPAK GROUP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 99 Gresham Street London EC2V 7NG |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENVOPAK GROUP?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ENVOPAK LIMITED | 08. Jan. 1958 | 08. Jan. 1958 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENVOPAK GROUP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENVOPAK GROUP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2011 bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ola Tricia Aramita Barreto-Morley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Philip Matthew Deakin am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Edward Ufland am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Giles Hudson am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für S & J Registrars Limited am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Udall als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ola Tricia Aramita Barreto-Morley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Philip Matthew Deakin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2006 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENVOPAK GROUP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Geschäftsführer | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Geschäftsführer | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Geschäftsführer | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 161583790001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Geschäftsführer | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| HOULDSWORTH, Raymond | Sekretär | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | 28059370001 | ||||||||||
| PIPER, Maurice George | Sekretär | 8 Chestnut Lane Matfield TN12 7JL Tonbridge Kent | British | 8141120001 | ||||||||||
| PROBERT, Clive Michael Douglas | Sekretär | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | 10804410001 | ||||||||||
| WICKETT, Edna May | Sekretär | 55 Ladbrooke Crescent Albany Park DA14 4RU Sidcup Kent | British | 36891520001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Sekretär | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 | ||||||||||
| ARTHUR, Frank Henry | Geschäftsführer | Well Hill Cottage Well Hill BR6 7RL Chelsfield Kent | England | British | 8141130001 | |||||||||
| BANGLE, Alfred Richard George | Geschäftsführer | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | 20981040001 | ||||||||||
| BANGLE, Alfred Richard George | Geschäftsführer | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | 20981040001 | ||||||||||
| BLACK, Stephen | Geschäftsführer | Les Vielles Terres Havelet GY1 1AZ St Peter Port Guernsey | British | 73554610001 | ||||||||||
| CAMERON, Ian Donald | Geschäftsführer | The Old Rectory Peasemore RG16 0JH Newbury Berkshire | British | 13521010001 | ||||||||||
| HENSHAW, Robert Charles Mayon | Geschäftsführer | 89 Sherbrooke Road SW6 7QL London | British | 66661330001 | ||||||||||
| HOLLINGSWORTH, Roger Colin | Geschäftsführer | 97 Copse Avenue BR4 9NW West Wickham Kent | British | 20963700001 | ||||||||||
| HOULDSWORTH, Raymond | Geschäftsführer | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | 28059370001 | ||||||||||
| KIRBY, Robert Bernard | Geschäftsführer | 1 Manor House Drive Crawford WN8 9QZ Upholland Lancashire | England | British | 221394890001 | |||||||||
| LEWIS, Thomas Arwyn | Geschäftsführer | 35 Clos Glanlliw Pontlliw SA4 9DW Swansea West Glamorgan | British | 65122490001 | ||||||||||
| O'DOHERTY, Jean Crichton | Geschäftsführer | 2g The Glebe Blackheath SE3 9TT London | England | British | 13964410001 | |||||||||
| PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir | Geschäftsführer | Kings Walden Bury SG4 8JU Hitchin Herts | England | British | 5324930001 | |||||||||
| PROBERT, Clive Michael Douglas | Geschäftsführer | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | 10804410001 | ||||||||||
| REED, Peter John | Geschäftsführer | 116 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | 21740620001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Geschäftsführer | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| UDELHOFEN, Mark James | Geschäftsführer | 771 Revere Road Glen Ellyn Illinois 60137 Usa | American | 84364350001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Geschäftsführer | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 |
Hat ENVOPAK GROUP Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Nov. 2000 Geliefert am 16. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Juli 1998 Geliefert am 25. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juni 1995 Geliefert am 06. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 1993 Geliefert am 06. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. März 1987 Geliefert am 03. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 16. März 1987 Geliefert am 20. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Sept. 1986 Geliefert am 20. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juli 1970 Geliefert am 29. Juli 1970 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 14. Juni 1968 Geliefert am 28. Juni 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 06. Jan. 1965 Geliefert am 07. Jan. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0