FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00598098 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 1 Seiten | AC92 | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Andrew Tatford am 31. Aug. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Notification of Qcc Holdings Limited as a person with significant control on 26. März 2018 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Estates Property Investment Company Limited as a person with significant control on 26. März 2018 | 3 Seiten | PSC07 | ||
Change of details for Estates Property Investment Company Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Alexander Edward Compton Hare am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Andrew Tatford am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 43-45 Portman Square London W1H 6LY zum 180 Great Portland Street London W1W 5QZ am 03. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Alexander Edward Compton Hare am 12. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 9 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Daniel Mark Greenslade als Geschäftsführer am 17. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Simon Andrew Tatford als Direktor am 17. März 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Alexander Edward Compton Hare als Direktor am 05. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Sandra Judith Odell als Sekretär am 05. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Sandra Judith Odell als Geschäftsführer am 05. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARE, Alexander Edward Compton, Mr | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 215786330002 | |||||
| TATFORD, Simon Andrew | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 228195340002 | |||||
| COOK, Anthony | Sekretär | Flat 81 Darwin Court 2-24 Gloucester Avenue NW1 7BQ London | British | 8492960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Sekretär | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Sekretär | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Sekretär | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Sekretär | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104180001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Sekretär | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Sekretär | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Sekretär | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Sekretär | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Geschäftsführer | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Geschäftsführer | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Geschäftsführer | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Geschäftsführer | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Geschäftsführer | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 164108510002 | |||||
| JONES, Christopher Neville | Geschäftsführer | 55 York Mews GU34 1JD Alton Hampshire | England | British | 109266700001 | |||||
| ODELL, Sandra Judith | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 132142980001 | |||||
| RILEY, Michael Edward | Geschäftsführer | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Geschäftsführer | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| STRINGER, Reginald | Geschäftsführer | Pipers Landing Green Lane Albury GU5 9EP Guildford | British | 11500100002 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Geschäftsführer | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WINGATE, Stephan Anthony | Geschäftsführer | 58 Pont Street SW1X 0AE London | United Kingdom | British | 33528820002 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Geschäftsführer | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Geschäftsführer | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qcc Holdings Limited | 26. März 2018 | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Estates Property Investment Company Limited | 06. Apr. 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental trust deed | Erstellt am 24. März 1993 Geliefert am 29. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 10% secured loan stock 1993/98 and all other monies due from estates property investment company limited to sun alliance trust company limited pursuant to the second supplemental trust deed dated 29TH march 1993 | |
Kurze Angaben Land and premises k/a ramus tiles unit broad ground road lakeside west reddich county of hereford and worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and charge | Erstellt am 17. Juni 1991 Geliefert am 24. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by a deed dated 28TH april 1986, deeds supplemental thereto and this charge. | |
Kurze Angaben F/H land and buildings known as ramus tiles unit, broad ground road, lakeside west, redditch, hereford and worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Juli 1990 Geliefert am 13. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings on the south side of bond road, mitcham and k/a blocks g, s & m, the james estate assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental mortgage and release | Erstellt am 08. Juni 1989 Geliefert am 15. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,600,000 due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The ramus tiles, unit, broadground road, redditch hereford and worcestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental mortgage and release | Erstellt am 22. März 1989 Geliefert am 30. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,115,500 & all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 25.3.76 and legal charges dated 30.9.76 and 16.12.77 | |
Kurze Angaben F/H- units E7, f and H5, stanley green trading estate situated in cheadle hulme, great manchester and wilmslow, cheshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1989 Geliefert am 23. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to south of stanley green road, cheadle hulme, greater manchester and wilmslow, cheshire k/a units D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, g, k, a, p and E1 at stanley green trading estate and unit 2/1 at stanley green trading estate (formerley title no ch 221436 and part of no. Ch 196140). floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Nov. 1988 Geliefert am 25. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or estates property investments company limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben St. Georges business park, situate at locke king road and brooklands road weybridge, surrey title no sy 262247. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & charge | Erstellt am 15. Jan. 1988 Geliefert am 18. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 28.4.86. | |
Kurze Angaben F/H land at broad ground road lakeside west redditch hereford & worcester tog with all buildings & erections fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Okt. 1986 Geliefert am 16. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £780,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Supplemental to a mortgage 21/5/71 | |
Kurze Angaben F/Hold unit E7 stanley green trading estate cheadle hulme cheshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1986 Geliefert am 09. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit B1 stanley green trading estate, cheadle hulme cheshire together with all buildings and fixed plant, machinery and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1986 Geliefert am 09. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit r s and u stover trading estate yate bristol avon. Together with all buildings, fixed plant, machinery and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 28. Apr. 1986 Geliefert am 30. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estate property investment company PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed | |
Kurze Angaben Various l/hold and f/hold properties in cheshire, greater manchester and leeds. Together with all buildings and erections and fixtures (includign tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being cheseam see doc M132 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1986 Geliefert am 01. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or estates property investments co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Part of the james estate western rd, mitcham, surrey known as unit 1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1986 Geliefert am 01. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or estates property investments co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Units E9, E10 & E11 stanley green trading estate, cheadle hulme, cheshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1986 Geliefert am 01. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or estates property investment co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Units a, t & W. stover trading estate, yate, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Apr. 1986 Geliefert am 30. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the charge and/or estates property investment company PLC to the chargee | |
Kurze Angaben Units a and p stanley green trading estate cheadle hulme cheshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. März 1985 Geliefert am 04. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north westside of tribune drive sittingbourne kent. (See doc m 129 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Mai 1984 Geliefert am 12. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the north west & south east sides of tribune drive, sittingbourne, kent together with the buildings and all fixed plant machiner & fixtures thereon. Title no. K 254683. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, p and q stover trading estate, yate, bristol together with the buildings and all fixed plant machinery and fixtures therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units a-h seacroft industrial estate, coal road, seacroft, leeds. Together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1-3 bessemer road, cardiff, together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north west side of elland road leeds. West yorkshire. Title no. Yk 9717. together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the north west of cheatsey road, byfleet, woking, surrey, title no. Sy 300102. together with the buildings and all fixed plant machinery & fixture thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units D8, D9, D10/11 stanley green trading estate, cheadle, hulme cheshire. Together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1984 Geliefert am 11. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units D1/D2, d 3/4, D5, D6 and D7 stanley green grading estage, cheadle, hulme, cheshire. Together with the buildings and all fixed plant machinery and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0