LP TOWER LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LP TOWER LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00603342 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LP TOWER LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LP TOWER LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gleadhill House Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Lancashire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LP TOWER LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BLACKPOOL TOWER COMPANY LIMITED(THE) | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
THEATRE RESTAURANTS LIMITED | 23. Apr. 1958 | 23. Apr. 1958 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LP TOWER LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LP TOWER LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 97 Church Street Blackpool Lancashire FY1 1HL am 05. Okt. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Lorimer Widders am 20. Jan. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 20. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Kathryn Revitt am 20. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Craig John Hemmings am 20. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LP TOWER LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDDERS, Mark Lorimer | Sekretär | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | British | Chartered Accountant | 2272770002 | |||||
HEMMINGS, Craig John | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | United Kingdom | British | Director | 180952730001 | ||||
REVITT, Kathryn | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | United Kingdom | British | Solicitor | 49315020001 | ||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | England | British | Chartered Accountant | 2272770002 | ||||
DREGENT, Patricia Ann Taylor | Sekretär | 17 Spinney Close RM13 8LR Rainham Essex | British | 6369240002 | ||||||
REVITT, Karhryn | Sekretär | 3 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | British | Solicitor | 60249750001 | |||||
ASHWORTH, Paul Richard | Geschäftsführer | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | England | British | Accountant | 46410260001 | ||||
CHAPMAN, David Thomas | Geschäftsführer | 20 The Royals Linksgate FY8 3LJ Lytham St Annes Lancashire | England | British | Operations Manager | 43071850006 | ||||
ETCHES, Marc Warren | Geschäftsführer | East Dene Brettargh Drive Haverbreaks LA1 5BN Lancaster Lancashire | British | Company Director | 61366690003 | |||||
FOSTER, Michael Raymond | Geschäftsführer | 4 Church Close Westoning MK45 5DH Bedford | England | British | Chartered Accountant | 53280440001 | ||||
GRAY, David Henry | Geschäftsführer | Arbor Low 39 Hainault Road IG7 5DQ Chigwell Essex | British | Group Treasurer | 6369250001 | |||||
KILBY, Eric Melvyn | Geschäftsführer | White Lodge Broadway Hale WA15 0PQ Altrincham Cheshire | British | Company Director | 165870002 | |||||
REVITT, Karhryn | Geschäftsführer | 3 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | British | Solicitor | 60249750001 | |||||
SHILLINGLAW, Gary Preston | Geschäftsführer | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | England | British | Company Secretary | 66825690001 | ||||
SULLIVAN, Christopher John | Geschäftsführer | 8 Spring Gardens Waddington BB7 3HH Blackburn Lancashire | England | British | Director | 101400140001 | ||||
WRIGHT, David William | Geschäftsführer | The Oast House Shernfold Park Farm TN3 9DL Frant East Sussex | United Kingdom | British | Company Secretary | 83417990001 |
Hat LP TOWER LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 04. Sept. 2007 Geliefert am 14. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Juli 2007 Geliefert am 07. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land k/a 21/29 (odd) the strand, blackpool and land and buildings at the rear thereof t/no LA829432. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from first leisure corporation limited to creditanstalt bankerven supplemental to a loan agreement dated 14 jan 1983 | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts uncalled capital stocks shares & other securities all licenses held by the company in connection with the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from first leisure corporation limited to first national boston limited (as agent) supplemental to a loan agreement dated 14 jan 1983 | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts uncalled capital, stocks, shares & other securities all licenses held by the company in connection with the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from first leisure corporation limited to national westminster bank PLC supplemental to a loan agreement dated 14 jan 1983 | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts uncalled capital, stocks shares & other securities all licenses held by the company in connection with the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from first leisure corporation limited to bank of montreal supplemental to a loan agreement to dated 14 jan 83 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts uncalled capital stocks, shares & other securities, all licenses held by the company in connection with its business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from first leisure corporation limited to first national boston limited supplemental to a loan agreement dated 14 jan 83 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts uncalled capital stocks, shares & other securities, all licences held by the company in connection with its business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1983 Geliefert am 25. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from first leisure corporation limited to the chargee supplemental to an agreement dated 14 jan 1983 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book and other debts uncalled capital stocks shares or other securities together with all buildings fixtures thereon. Benefit of all licences held. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0