RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
Unternehmensnummer | 00606408 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Manchester M60 4ES |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
JNO. STEEL HOLDINGS LIMITED | 10. Okt. 1995 | 10. Okt. 1995 |
JNO.STEEL & SON LIMITED | 17. Juni 1958 | 17. Juni 1958 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Jan. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Forms b & z - convert to i&ps | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Oldale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 11. Jan. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Samuel Patrick Donald Kershaw am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Jan. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 12. Jan. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a |
Wer sind die Geschäftsführer von RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | 45801060004 | ||||||
KERSHAW, Samuel Patrick Donald | Geschäftsführer | 111 Cowper Road Boxmoor HP1 1PF Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | Operations Director | 101845900003 | ||||
OLDALE, Andrew | Geschäftsführer | New Century House Manchester M60 4ES | England | British | Accountant | 167083200001 | ||||
TINNING, George Murray | Geschäftsführer | 17 Briar Road Kirkintilloch G66 3SA Glasgow | United Kingdom | British | Group Operations Manager | 126913730001 | ||||
GREENFIELD, Phillip Lee Richard | Sekretär | Wharf Road OX10 7EW Shillingford The Nook Oxfordshire | British | Director | 161062970001 | |||||
HAAKSTAD, Sherolyn | Sekretär | 4 Ashurst Court 3 Belvedere Grove SW19 7RQ London | Canadian | 62593000001 | ||||||
MITCHELL, Clare Marion | Sekretär | 111 Wolsey Drive KT2 5DR Kingston Surrey | British | 72762420001 | ||||||
PANTELI, Andreas | Sekretär | 61 Ashley Road KT18 5BN Epsom Surrey | British | Finance Director | 109275700001 | |||||
STEEL, Iain Harfield | Sekretär | 26 Olivers Battery Road North SO22 4JA Winchester Hampshire | British | 22071640005 | ||||||
AYLWIN, Nicholas Claude | Geschäftsführer | Blairmore House 27 Ellerton Road SW20 0EW London | England | British | Company Director | 52106130001 | ||||
BECKETT ALLEN, Anne | Geschäftsführer | The Thatched Cottage Bungay Road Scole IP21 4DT Diss Norfolk | England | English | Funeral Director | 64862160006 | ||||
CARPENTER, Paul Kenneth Christopher | Geschäftsführer | Grasmere 36 Chester Road SK12 1EU Poyton Cheshire | British | Accountant | 119893930001 | |||||
GREENFIELD, Phillip Lee Richard | Geschäftsführer | Wharf Road OX10 7EW Shillingford The Nook Oxfordshire | England | British | Director | 161062970001 | ||||
HAAKSTAD, Sherolyn | Geschäftsführer | 4 Ashurst Court 3 Belvedere Grove SW19 7RQ London | Canadian | Finance Director | 62593000001 | |||||
HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | Cardney Estate Butterstone PH8 0EY By Dunkeld Over Cardney Farmhouse Perthshire | Scotland | British | Director | 128555100001 | ||||
HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | Cardney Estate Butterstone PH8 0EY By Dunkeld Over Cardney Farmhouse Perthshire | Scotland | British | Director | 128555100001 | ||||
HEWITT, Paul William | Geschäftsführer | Hough Hall Newcastle Road Hough CW2 5JG Crewe Cheshire | England | British | Deputy Chief Executive | 163759450001 | ||||
HOLMES, Susan | Geschäftsführer | 14 The Avenue RG45 6PD Crowthorne Berkshire | British | Director | 67967870001 | |||||
HULME, Martyn Alan | Geschäftsführer | 20 Walton Heath Drive SK10 2QN Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | Director Of Business Support | 77326830003 | ||||
SHEPPARD, Derek Wilfred | Geschäftsführer | Oakwood Cottage 45 Oakwood Road Chandlers Ford SO53 1LW Eastleigh Hampshire | British | Director | 2536290001 | |||||
STEEL, Iain Harfield | Geschäftsführer | The White House 77 Lakewood Road SO53 5AD Chandlers Ford Hampshire | England | British | Director | 154871340001 | ||||
STEEL, Marjorie Alice | Geschäftsführer | Tegfield House 24 Chilbolton Avenue SO22 5HD Winchester Hampshire | British | Director | 22071650002 | |||||
STEEL, Richard Francis John | Geschäftsführer | The Granary Whiteparish SP5 2QE Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 36296600002 | ||||
STEWART, William Gerald | Geschäftsführer | 5282 Upland Drive VAM 2GS Delta British Columbia Canada | Canadian | Businessman | 55680800001 | |||||
TAYLOR, Nicholas Vincent | Geschäftsführer | Moat Farm Upgate Street Bedingham NR35 2AT Bungay | British | Undertaker | 23452670004 | |||||
TINNING, George Murray | Geschäftsführer | 17 Briar Road Kirkintilloch G66 3SA Glasgow | United Kingdom | British | Director | 126913730001 | ||||
WAGLER, Paul | Geschäftsführer | 2779 West 24th Avenue VGN 2JS Vancouver British Columbia Canada | Canadian | Businessman | 59792750001 | |||||
WALKER, Neil James | Geschäftsführer | 224a Bramhall Lane South Bramhall SK7 3AA Stockport Cheshire | England | British | Accountant | 126913860001 |
Hat RAMALLEY FUNERAL SERVICE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 10. Sept. 1997 Geliefert am 12. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 161 woodmill lane southampton hampshire t/no's HP131667 and HP301055. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 01. Feb. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 73 leigh rd,eastleigh,hampshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hp 339652. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 22. Dez. 1994 Geliefert am 30. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 163 hursley road, chandlers ford eastleigh, hampshire t/no: HP229531 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1990 Geliefert am 28. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as homedene bank street bishops waltham in hampshire. The proceeds of sale together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Sept. 1990 Geliefert am 12. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Chapel of rest, little shore lane, bishops waltham, nr winchester.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Sept. 1990 Geliefert am 12. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Furneral directors business adjoining "homedene" bank street bishops waltham in hampshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 24. Apr. 1990 Geliefert am 26. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. Dez. 1989 Geliefert am 07. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 485/487/489 bitterne road bitterne southampton. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. Juli 1987 Geliefert am 13. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 46, st. Johns rd, hedge end, southampton, the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 27. Jan. 1986 Geliefert am 13. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H spinnaker offcuts builders yard at tenyson road, freshwater isle of wight and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1985 Geliefert am 29. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H st. Peter's gallery, chesil st winchester hamps and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 07. Feb. 1985 Geliefert am 19. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 48A st. Johns road, hedge end, southampton hampshire and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Dez. 1984 Geliefert am 20. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 6 chesil street, winchester hampshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. Nov. 1984 Geliefert am 20. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 2 chesil street winchester hampshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 01. Mai 1979 Geliefert am 08. Mai 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as 4 chesil street, winchester hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0