GE REAL ESTATE LOANS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GE REAL ESTATE LOANS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00606529 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| REAL ESTATE LOANS LIMITED | 18. Jan. 2012 | 18. Jan. 2012 |
| BISHOPSWOOD PROPERTIES LIMITED | 18. Juni 1958 | 18. Juni 1958 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Change of details for Ge Real Estate (Investment Property Company) Limited as a person with significant control on 17. Aug. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Roy Slocombe als Geschäftsführer am 28. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Roy Slocombe als Sekretär am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 15. Jan. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Stewart Girling als Direktor am 11. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Damien Ivo Karlov als Geschäftsführer am 28. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Manager Derek Carter als Direktor am 24. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anupam Manchanda als Geschäftsführer am 02. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Panayot Kostadinov Vasilev als Geschäftsführer am 18. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Roy Slocombe als Direktor am 11. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Neville Bowden als Geschäftsführer am 13. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Damien Ivo Karlov als Direktor am 02. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER, Derek | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 225848070001 | |||||
| GIRLING, Paul Stewart | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 225432580001 | |||||
| BAMBER, Janine Margaret | Sekretär | 105 Shepperton Road N1 3DF London | British | 117898690002 | ||||||
| BEWSEY, Martin Roy | Sekretär | 16 Hawthorne Road BR1 2HH Bromley Kent | British | 88472130001 | ||||||
| BROWN, Grace | Sekretär | 35 Corringham Road Wembley Park HA9 9PX Wembley Middlesex | British | 102074060001 | ||||||
| KEARLEY, Andrew Paul | Sekretär | 12 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | 26039210001 | ||||||
| MANNING, John Ronald | Sekretär | 19 Pinewood Avenue TN14 5AE Sevenoaks Kent | British | 29806870001 | ||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Sekretär | More London Place SE1 2AF London 1 | British | 55097590003 | ||||||
| WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons | Sekretär | Meadow Cottage Hawksfold Lane GU27 3JW Fernhurst Surrey | British | 85529340001 | ||||||
| ABRAMSON, Christoffer | Geschäftsführer | 37-39 Abingdon Road Flat 2 W8 6AH London | Swedish | 98463110005 | ||||||
| BARTRAM, Christopher John | Geschäftsführer | 15 Trumpington Road CB2 2AJ Cambridge | England | British | 38758710002 | |||||
| BOTHA, Stephanie | Geschäftsführer | 5 Highbridge Wharf Highbridge SE10 9PS London | American | 116663740001 | ||||||
| BOWDEN, Matthew Neville | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183344960001 | |||||
| CASEY, Shay Andrew | Geschäftsführer | Flat 3 St Mary Hall 106 Felsham Road SW15 1DQ London | United Kingdom | Irish | 90824990003 | |||||
| CHALLE, Gregoire Marie Philippe | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | French | 183360310001 | |||||
| COLLETT, Melanie Jacqueline | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 173277230001 | |||||
| COLLETT, Melanie Jacqueline | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 173277230001 | |||||
| CONNELLAN, Paul Francis | Geschäftsführer | 7 Spencer Road TW7 4BQ Isleworth Middlesex | British | 67336830001 | ||||||
| DEBNEY, Richard Johnathon | Geschäftsführer | 81 Manor Way Blackheath SE3 9XG London | England | British | 59232720003 | |||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Geschäftsführer | 33 Gorst Road Battersea SW11 6JB London | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||
| DELANEY, Martin Peter | Geschäftsführer | 4 Hillside Road WD7 7BH Radlett Hertfordshire | England | British | 6499050001 | |||||
| EDWARDS, Jeremy Colin Gamul | Geschäftsführer | Dray House Broomrigg Road GU13 8LR Fleet Hampshire | England | British | 225698250001 | |||||
| FELCE, Gary John | Geschäftsführer | 25 Ickwell Road Northill SG18 9AB Biggleswade Bedfordshire | England | British | 107819460001 | |||||
| FREE, Nicola | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 164473860001 | |||||
| GATISS, Ian William | Geschäftsführer | Coleridge Road CB1 3PH Cambridge 61 Cambridgeshire | England | British | 95094220003 | |||||
| GILBERT, Donald Peter | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 158328310001 | |||||
| HARRIS, Neil Jason | Geschäftsführer | Pattison Lane Woolstone MK15 0AU Milton Keynes 11 Buckinghamshire | England | British | 94095660004 | |||||
| HUNTER, Randall Leon | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | American | 173280880001 | |||||
| JEVNE, Anne | Geschäftsführer | 26 Amner Road SW11 6AA London | Norwegian | 126577610001 | ||||||
| JEVNE, Anne | Geschäftsführer | Flat 8 70 Ironmonger Row EC1V 3QR London | Norwegian | 106807190001 | ||||||
| KARLOV, Damien Ivo | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Irish | 202318870001 | |||||
| KEARLEY, Andrew Paul | Geschäftsführer | 12 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | 26039210001 | ||||||
| LEE, David Robert | Geschäftsführer | 2 Thurlow Close SG1 4SD Stevenage Hertfordshire | British | 76032910002 | ||||||
| LEWIS, Martyn Phillips | Geschäftsführer | Wyncroft Ringmore TQ7 4HL Kingsbridge Devon | England | British | 96177720001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GE REAL ESTATE LOANS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Real Estate (Investment Property Company) Limited | 03. Juni 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GE REAL ESTATE LOANS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 16. Juni 2003 Geliefert am 18. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a chichester house 272-282 high holborn london WC2 t/no 430902. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Juni 2003 Geliefert am 18. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a west side of west gate leeds k/a 1 park lane leeds t/no WYK550759. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Juni 2003 Geliefert am 18. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a kingston house estate portsmouth road surbiton surrey and land and buildings on the south east side of portsmouth road surbiton surrey t/nos SY694988 and SY694989. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed security document | Erstellt am 16. Dez. 2002 Geliefert am 23. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Present real property, other assets and assignments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Juli 1998 Geliefert am 04. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or pillar property developments limited (together the borrowers) to the chargee under or in connection with the facility agreement dated 22ND july 1998 | |
Kurze Angaben F/H property being land on the south east side of cutenhoe road luton t/no.BD120294 and also any fixed machinery buildings or other erections and fixtures and fittings. By way of first fixed charge any sum paid out on any insurance policy, any deposit, all rents, any cash deposit. Floating charge over all undertaking property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Feb. 1998 Geliefert am 26. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The olbigations of the company to the chargee under an option agreement of even date in respect of the sale and purchase of the property thereby charged including the obligation of the company to repay £500,000 to the chargee in the event of non exercise of the option | |
Kurze Angaben F.h st clements house 33 35 and 37 church street walton on thames t/n SY337136. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 1997 Geliefert am 16. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £600,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All that f/h property at walton on thames town centre site under t/nos.SY400665, SY515430, SY588597, SY66634, SY587139, SY529204 (part) and SY131701 (part). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. März 1978 Geliefert am 31. März 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £6,800,000 advanced to haslemere estates LTD. | |
Kurze Angaben 3 craven hill paddington westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. März 1978 Geliefert am 31. März 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,200,000 advanced to haslemere estates LTD. | |
Kurze Angaben 170 westminster bridge rd lambeth london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 06. Feb. 1962 Geliefert am 16. Feb. 1962 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben 1. haslemere road, hornsey, title no. Mx 177849. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 09. Mai 1961 Geliefert am 10. Mai 1961 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben Leith house, gresham st. London title no. 318166. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 15. Jan. 1960 Geliefert am 15. Jan. 1960 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,000. | |
Kurze Angaben 25, augusta gardens, folkestone, kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Nov. 1959 Geliefert am 09. Nov. 1959 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc. | |
Kurze Angaben 48/49 crawford street & 94A seymounr place, london W.1, including all trade & other fixtures present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GE REAL ESTATE LOANS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0