D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameD S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00610733
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DEVELOPMENT SECURITIES DEVELOPMENTS LIMITED26. Okt. 199326. Okt. 1993
    CLAYFORM DEVELOPMENTS LIMITED22. Okt. 198722. Okt. 1987
    ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED04. Sept. 195804. Sept. 1958

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. März 2021 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 95 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 96 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 97 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019

    19 SeitenAA

    Zweite Einreichung für die Abberufung von James Simon Hesketh als Geschäftsführer

    5 SeitenRP04TM01

    Beendigung der Bestellung von James Simon Hesketh als Geschäftsführer am 08. Aug. 2019

    2 SeitenTM01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    09. Sept. 2019Clarification A second filed TM01 was registered on 09/09/2019.

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. März 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2019 bis 31. März 2019

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2018

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. März 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Bradley David Cassels als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2017

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2016

    18 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Charles Julian Barwick als Geschäftsführer am 07. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. März 2016

    Kapitalaufstellung am 22. März 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Michael Henry Marx als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard Upton als Direktor am 08. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Bradley David Cassels als Direktor am 08. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von James Simon Hesketh als Direktor am 29. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Charles Julian Barwick am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Sekretär
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    194325750001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish41925000005
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish72888710004
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Sekretär
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    British8606990001
    CROMPTON, Rita Mary
    36 Priory Avenue
    N8 7RN London
    Sekretär
    36 Priory Avenue
    N8 7RN London
    British4779150001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Sekretär
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158442850001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659730001
    BARWICK, Charles Julian
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish3818640003
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Geschäftsführer
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    British34902790002
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish8606990001
    BURLETSON, Bryan Richard
    Farmhouse
    Templecombe
    RG9 3HP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Farmhouse
    Templecombe
    RG9 3HP Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish57633110005
    CASSELS, Bradley David
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish130724370005
    CHATTERJEE, Vivienne Teresa
    18 Belsize Crescent
    NW3 5QU London
    Geschäftsführer
    18 Belsize Crescent
    NW3 5QU London
    British9092320001
    CHEER, Bruce Baxter
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    British66762930001
    DOWLING, Brian Sidney Preston
    Crest House
    Silver Street Goffs Oak
    EN7 5JE Cheshunt
    Geschäftsführer
    Crest House
    Silver Street Goffs Oak
    EN7 5JE Cheshunt
    British36851910001
    GEE, Peter Peregrine Simpson
    Rowells Lodge Ayston Road
    Ridlington
    LE15 9AH Oakham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Rowells Lodge Ayston Road
    Ridlington
    LE15 9AH Oakham
    Leicestershire
    British68168890001
    HESKETH, James Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish124650200001
    LANDAU, Martin Richard
    Le Schuylkill
    19 Boulevard De Suisse
    MC98000 Monaco
    Monaco
    Geschäftsführer
    Le Schuylkill
    19 Boulevard De Suisse
    MC98000 Monaco
    Monaco
    MonacoBritish731130002
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    PEARSE, Raymond Henry
    79 The Green
    KT17 3JX Ewell
    Surrey
    Geschäftsführer
    79 The Green
    KT17 3JX Ewell
    Surrey
    United KingdomBritish41761870001
    PROTHERO, Graham
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    United KingdomBritish134427450001
    VAUGHAN, Steven Mark
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    British9092330001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    British4779170001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02850465
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge of partnership interest
    Erstellt am 25. Juni 2010
    Geliefert am 05. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the partnership share. Partnership share means the existing or future interest including any income, offer, right or benefit.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1998
    Geliefert am 06. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and development securities (no. 1) limited (as borrower) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold properties k/a 209-211 high street bangor, 52 and 54 bebington road wirral new ferry, 16-16A high street newhaven, 3 and 5 church street wilmslow and heath town (or crossways) shopping centre deans road wolverhampton t/n WA701331,MS118386,ESX86619,CH222953,WM400955. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 1995
    Geliefert am 20. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or by development securities estates PLC or by development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various properties specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1995
    Geliefert am 04. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or development securities estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sutherland house brighton road sutton l/b of sutton t/no SGL15039.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1995
    Geliefert am 04. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or development securities estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    St nicholas house st nicholas way sutton l/b of sutton t/no SGL18986.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1994
    Geliefert am 30. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sutherland house brighton road sutton london borough of sutton t/n SGL15039.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1994
    Geliefert am 30. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    St nicholas house st nicholas road sutton london borough of sutton t/n sgl 18986.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee ) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge with the payment to the security agent as trustee for the beneficiaries of the secured obligations the whole of its undertaking property rights and assets both present and future and wheresoever situate.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as heath town shopping centre deans road wolverhampton west midlands.t/no.WM400955. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 3 and 5 church street wilmslow cheshire.t/no.CH222953. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined)under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 75 widnes road widnes cheshire.t/no.CH212592. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 5 watergate street whitchurch shropshire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as bredwood arcade whitchurch shropshire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent)or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 52 & 54 bebington road new ferry wirral merseyside.t/no.MS118386. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 16/16A high street newhaven east sussex.t/no.ESX86619. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 209/211 high street bangor gwynedd wales. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/as the austin trading estate (on the north and north east sides of hornhouse lane and on the south east side of south boundary road kirkby) knowsley merseyside.t/nos.MS102296 and MS102297. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 10 high street neston cheshire.t/no.CH252473. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as the nelson bulkeley square llangefni wales.t/no.WA571332. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 115 king street knutsford cheshire.t/no.CH186749. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 79 king street knutsford macclesfield cheshire.t/no.CH141067. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent)or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 8/10 abergele road colwyn bay clwyd wales. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined)to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee)to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as unit 4 grosvenor court foregate street chester cheshire.t/no.CH312044. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent)or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 9 wrawby street brigg humberside. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/as 237 high street bangor gwynedd wales. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0