CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED

CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00623197
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CABLE AND SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED12. Dez. 198912. Dez. 1989
    TELEVISION ENTERTAINMENT BY CABLE LIMITED30. Okt. 198630. Okt. 1986
    THORN EMI CABLE TELEVISION LIMITED02. März 198402. März 1984
    RADIO RENTALS CABLE TELEVISION LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    RED DRAGON RELAYS LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    TRADERS TELEVISION RELAY LIMITED16. März 195916. März 1959

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 160 Great Portland Street London W1W 5QA am 04. Apr. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    legacy

    25 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG04

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Directors Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Gillian Elizabeth James als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Robert Mario Mackenzie als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Robert Charles Gale als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151008540001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    HOWARD, Kenneth John
    4 Alderbrook
    Cyncoed
    CF23 6QD Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    4 Alderbrook
    Cyncoed
    CF23 6QD Cardiff
    South Glamorgan
    British74710920001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    LUMSDEN, Joan Mary
    3 Roman Crescent
    SN1 4HH Swindon
    Wiltshire
    Sekretär
    3 Roman Crescent
    SN1 4HH Swindon
    Wiltshire
    British3254530001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    OBRIEN, Jill
    72 Sandringham Road
    SN3 1HX Swindon
    Wiltshire
    Sekretär
    72 Sandringham Road
    SN3 1HX Swindon
    Wiltshire
    British24246770001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    AUER, Adrian Richard
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    United KingdomBritish105271660001
    BARLOW, Graham Sydney
    6 Gelli Geiros
    Pontardawe
    SA8 3DZ Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    6 Gelli Geiros
    Pontardawe
    SA8 3DZ Swansea
    West Glamorgan
    British21434590001
    BARTER, James Terrence
    Pant Glas
    2 Howard Bowen Close
    NP25 3AU Osbaston
    Gwent
    Geschäftsführer
    Pant Glas
    2 Howard Bowen Close
    NP25 3AU Osbaston
    Gwent
    British75642590001
    BLUMENTHAL, George
    900 Park Avenue
    New York
    FOREIGN Usa
    Geschäftsführer
    900 Park Avenue
    New York
    FOREIGN Usa
    Us Citizen36511670001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    DREW, Christopher John
    11 Mountjoy Avenue
    CF64 2SX Penarth
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    11 Mountjoy Avenue
    CF64 2SX Penarth
    South Glamorgan
    British38107580001
    EDWARDS, Gary David
    2 Heol Y Glo
    Tonna
    SA11 3NJ Neath
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    2 Heol Y Glo
    Tonna
    SA11 3NJ Neath
    West Glamorgan
    British20983710001
    EDWARDS, John Arwel, Dr
    10-11 George Bank
    Mumbles
    SA3 4EQ Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    10-11 George Bank
    Mumbles
    SA3 4EQ Swansea
    West Glamorgan
    British22763740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GRAVES, John Vincent
    29 Ashwood Drive
    Gellinedd, Pontadawe
    SA8 3HL Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    29 Ashwood Drive
    Gellinedd, Pontadawe
    SA8 3HL Swansea
    West Glamorgan
    British34048220001
    GRAVES, Michael Anthony
    Cefn Helog 1 Heol Graig Felen
    Clydach
    SA6 5DF Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    Cefn Helog 1 Heol Graig Felen
    Clydach
    SA6 5DF Swansea
    West Glamorgan
    United KingdomBritish42581690001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    HAZEN, John Dean
    41-921 Laumilo Street
    FOREIGN Honolulu
    Hawaii 96795
    Usa
    Geschäftsführer
    41-921 Laumilo Street
    FOREIGN Honolulu
    Hawaii 96795
    Usa
    United States21876140001
    HAZEN, Zoe
    41-921 Laumilo Street
    FOREIGN Honolulu
    Hawaii 96795
    Usa
    Geschäftsführer
    41-921 Laumilo Street
    FOREIGN Honolulu
    Hawaii 96795
    Usa
    United States21876130001
    HEIDARY, Hamid Reza
    Fairways West Hill Golf Course
    Bagshot Road
    GU22 0QZ Worplesdon Hill
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fairways West Hill Golf Course
    Bagshot Road
    GU22 0QZ Worplesdon Hill
    Surrey
    American48966390001
    JAMES, John Mansel
    Tesano
    Van
    SY18 6NG Llanidloes
    Powys
    Geschäftsführer
    Tesano
    Van
    SY18 6NG Llanidloes
    Powys
    British55503960001
    JONES, Stuart Nigel
    48 Beacons Park
    LD3 9BR Brecon
    Powys
    Geschäftsführer
    48 Beacons Park
    LD3 9BR Brecon
    Powys
    British41149470001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, Barclay
    59 Battle Road
    Princeton
    08540 New Jersey
    08540
    Usa
    Geschäftsführer
    59 Battle Road
    Princeton
    08540 New Jersey
    08540
    Usa
    American41358150002
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Geschäftsführer
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCKELLAR, Ronald Alexander
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    British7345780001

    Hat CABLETEL WEST GLAMORGAN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charges all right, title and interest in: 1) the english charged land 2) the tangible moveable property 3) the accounts 4) the intellectual property 5) any goodwill 6) the investments 7) the shares and all dividends 8) all monetary claims by way of assignment all right, title and interest in: 1) any insurance policy 2) all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings 3) chattels hired, leased or rented 4) licences held, by way of floating charge the whole undertaking and assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as second security trustee for the secured parties (the "second security trustee")
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 23. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 1997
    Geliefert am 30. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company (the "chargor") may now or hereafter have to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the facility documents including any liability in respect of any further advances made thereunder (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    (See schedules attached to from M395 for details of the property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0