CAPARO INDUSTRIES PLC
Überblick
| Unternehmensname | CAPARO INDUSTRIES PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | In Verwaltung |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 00630473 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAPARO INDUSTRIES PLC?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Floor 8 Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| L.K.INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED | 16. Juni 1959 | 16. Juni 1959 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2015 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2016 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 14. Juni 2017 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 28. Juni 2017 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 26 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 28 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 26 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 24 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters | 3 Seiten | AM11 | ||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 14 Seiten | AM16 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 26 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 26 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 14 Seiten | AM16 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 8 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 18 Seiten | AM16 | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters | 3 Seiten | AM11 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 30 Seiten | AM10 | ||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:C.O. To file progress reports annually not 6 monthly. | 3 Seiten | LIQ MISC OC | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 31 Seiten | AM10 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 7 More London Riverside London SE1 2RT zum Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL am 09. Okt. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 2 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 28 Seiten | AM10 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CAPARO INDUSTRIES PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Sekretär | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | 108203800001 | ||||||
| GARDNER, Norman Arthur | Sekretär | 210a Stroud Road GL1 5LA Gloucester Gloucestershire | British | 61016230001 | ||||||
| HYLAND, Matthew Edward William | Sekretär | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | 194838470001 | |||||||
| JEAVONS, William Geoffrey | Sekretär | 1 The Grange Wombourne WV5 9HX Wolverhampton West Midlands | British | 11293410001 | ||||||
| MASON, Georgina | Sekretär | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | 173195350001 | |||||||
| SMITH, John Godfrey | Sekretär | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | British | 56051330001 | ||||||
| SMITH, John Godfrey | Sekretär | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | British | 56051330001 | ||||||
| STEELE, Colin Grant | Sekretär | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 10618480001 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Sekretär | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | 150882120001 | |||||||
| BUTLER, Richard Gareth John | Geschäftsführer | The Field House Rashwood WR9 0BS Droitwich Spa Worcestershire | England | British | 117859680001 | |||||
| DANCASTER, David Patrick | Geschäftsführer | Kenilworth Avenue SW19 7LN London 1 | England | British | 55380530001 | |||||
| DAWSON, Douglas, Dr | Geschäftsführer | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | England | British | 117734230001 | |||||
| EMMENEGGER, Charles E | Geschäftsführer | 1819 Clarkson Road FOREIGN Chesterfield Missouri 63017 Usa | United States Of America | 37965200001 | ||||||
| GANE, Christopher Nigel | Geschäftsführer | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | Scotland | British | 73268030001 | |||||
| GARDNER, Norman Arthur | Geschäftsführer | 210a Stroud Road GL1 5LA Gloucester Gloucestershire | British | 61016230001 | ||||||
| HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor | Geschäftsführer | The Tile House 26 Pound Lane Sonning On Thames RG4 6XE Reading Berkshire | British | 12310490001 | ||||||
| HAUXWELL, Timothy Norbury | Geschäftsführer | The Shielings Highgrove Gardens Edwalton NG12 4DF Nottingham | British | 70993740001 | ||||||
| JARVIS, Andrew Laurence | Geschäftsführer | Beaumont Beaufort Road, Osbaston NP25 3HU Monmouth Monmouthshire | United Kingdom | British | 93158620001 | |||||
| LEEK, James Anthony | Geschäftsführer | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| LORMOR, Paul Frederick | Geschäftsführer | 23 Kirton Road Scotter DN21 3SW Gainsborough Lincolnshire | British | 30814040001 | ||||||
| MEYER, John Joseph | Geschäftsführer | 14929 Greenbury Hill Court Chesterfield Missouri 63017 Missouri | Usa | American | 147066260001 | |||||
| MORRILL, Dennis | Geschäftsführer | Raven Drive St Peters Park WR5 3LR Worcester 17 Worcestershire | United Kingdom | British | 111395730002 | |||||
| O'REILLY, Derek Michael | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2RT London 7 | England | British | 108440160002 | |||||
| PAHILAJANI, Sunil | Geschäftsführer | A-1, 54, Ground Floor Safdarjang Enclave New Dehli 110016 India | Indian | 119093750001 | ||||||
| PAUL, Akash, The Honourable | Geschäftsführer | Ambkia House 9a Portland Place W1B 1PR London Flat 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 49303360005 | |||||
| PAUL, Akhil | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2RT London 7 | United Kingdom | British | 147065830001 | |||||
| PAUL, Ambar, The Honourable | Geschäftsführer | Ambika House 9-11 Portland Place W1B 1PR London Flat 19 United Kingdom | United Kingdom | British | 92729600003 | |||||
| PAUL, Angad, The Honorable | Geschäftsführer | Ambika House 9a Portland Place W1B 1PR London The Penthouse Flat | United Kingdom | United Kingdom | 130813310001 | |||||
| PAUL, Anjli, The Hon | Geschäftsführer | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | United Kingdom | British | 110279150001 | |||||
| PAUL OF MARYLEBONE, The Lord | Geschäftsführer | 6 Ambika House 9a Portland Place W1B 1PR London | England | British | 11293420003 | |||||
| PAY, Jason Christopher | Geschäftsführer | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | England | British | 126516810001 | |||||
| SCHEELE, Nicholas, Sir | Geschäftsführer | Caparo House Popes Lane B69 4PJ Oldbury West Midlands | British American | 116839800001 | ||||||
| SHAW, Christopher Norman | Geschäftsführer | Castle Vale Castle Street, Raglan NP15 2DS Usk Gwent | United Kingdom | British | 28831060001 | |||||
| SMITH, John Godfrey | Geschäftsführer | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| STEELE, Colin Grant | Geschäftsführer | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10618480001 |
Hat CAPARO INDUSTRIES PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 27. Juni 2013 Geliefert am 15. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H real estate:. Cmt engineering, congreaves road, cradley heath t/no WM904133.. Units 9 & 13 -5-7 wenlock road, london t/no's EGL525392, EGL525389 and EGL525391.. Land adjoing walsall canal, old birchills, walsall t/no WM928137. (For further details of properties charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Juni 2013 Geliefert am 06. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H land adjoining walsall canal old birchills walsall t/no WM928137. F/h land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood t/no WM664003. F/h land and buildings o the north east side of miner street walsall t/no WM383832. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Juni 2013 Geliefert am 05. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H land k/a cmt engineering corngreaves road cradley heath t/no WM904133. F/h land (ground lease) k/a units 9 - 5-7 wenlock road london t/nos EGL525392, EGL525389, EGL525394 and EGL525391. Trade mark registered in the UK with number 2623030 in relation to the word mark "barton filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. trade mark registered in the republic of ireland with number N247732 in relation to the word mark "barton" filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Juni 2013 Geliefert am 01. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H property being the land adjoining walsall canal old birchills walsall (WM928137) land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood (WM664003) and land and building on the north east side of miner walsall (WM383832). Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 13. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest in the shares being 10,000 ordinary shares and all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 09. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property land adjoining walsall canal, old bircills walsall, t/no.WM928137; land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood, t/no.WM664003; land and buildings on the north east side of miner street walsall, t/no.WM383832 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 06. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All shares in caparo india limited and all related rights. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or geneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Shares mean in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 06. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 2009 Geliefert am 18. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a as land lying to the west of raybould's bridge road, reedswood, land adjoining walsall canal, old brichills, walsall and land and buildings to the north east side of miner street, walsall t/no WM66003, WM928137, and WM383832. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Juli 2007 Geliefert am 07. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H properties k/a units 9 and 13 and parking spaces 21 and 22 "estilo wenlock road london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Feb. 2007 Geliefert am 28. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a corngreaves road cradley t/no WM489303. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Apr. 1985 Geliefert am 12. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All ordinary and deferred shared in caparo management services limited held in the name of fenchurch securities LTD. All ordinary and deferred shares in barton group PLC owned by the charger. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CAPARO INDUSTRIES PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Receiver/Manager bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0