HAMPSON INDUSTRIES P.L.C.

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHAMPSON INDUSTRIES P.L.C.
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00631731
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HAMPSON INDUSTRIES P.L.C.?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HAMPSON INDUSTRIES P.L.C.?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o FTI CONSULTING LLP
    322 High Holborn
    WC1V 7PB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMPSON INDUSTRIES P.L.C.?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für HAMPSON INDUSTRIES P.L.C.?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 13. Nov. 2013

    19 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Mai 2013

    22 Seiten2.24B

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    52 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    53 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    62 Seiten2.16B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    13 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 7 Harbour Buildings Waterfront West Dudley Road Brierley Hill West Midlands DY5 1LN am 12. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2012 ohne Mitgliederliste

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Okt. 2012

    Kapitalaufstellung am 08. Okt. 2012

    • Kapital: GBP 69,824,005.75
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Peter George Barlow am 08. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2012 bis 30. Sept. 2012

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ram Swamy am 08. Feb. 2012

    2 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Beendigung der Bestellung von Stephen Hugh Henwood als Geschäftsführer am 30. Nov. 2011

    2 SeitenTM01

    Ernennung von John William Poulter als Direktor am 28. Okt. 2011

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Vincent Geoghegan als Geschäftsführer am 28. Okt. 2011

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    19 SeitenAR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    107 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    75 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11

    Ernennung von Mr Ram Swamy als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Howard Kimberley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von HAMPSON INDUSTRIES P.L.C.?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    BritishChartered Secretary73207060001
    BARLOW, Peter George
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector Of Finance77277970004
    GISMONDI, Paul Arthur
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    EnglandBritishInvestment Banker126431290002
    JORDAN, Norman Daniel
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    United States Of AmericaUnited StatesNone154057540001
    POULTER, John William
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector4333730005
    SWAMY, Ram
    c/o Fti Consulting Llp
    High Holborn
    WC1V 7PB London
    322
    Geschäftsführer
    c/o Fti Consulting Llp
    High Holborn
    WC1V 7PB London
    322
    EnglandBritishFinance Director156224980002
    KIMBERLEY, Howard Fraser
    8 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich Spa
    Worcestershire
    Sekretär
    8 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich Spa
    Worcestershire
    BritishFinance Director75325410002
    WELCH, John Reginald
    22 Balmoral Road
    Kingshurst
    B36 0JT Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    22 Balmoral Road
    Kingshurst
    B36 0JT Birmingham
    West Midlands
    British2243210001
    CLAYTON, Christopher John
    6 Summerhill Avenue
    DY11 6BU Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    6 Summerhill Avenue
    DY11 6BU Kidderminster
    Worcestershire
    BritishDirector1459780001
    CUTLER, John Leslie
    4 Claverdon Drive
    B74 3AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Claverdon Drive
    B74 3AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector1454360001
    DAVIES, Christopher Erith
    Hollytree The Common
    Wellington Heath
    HR8 1LY Ledbury
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Hollytree The Common
    Wellington Heath
    HR8 1LY Ledbury
    Herefordshire
    BritishChief Executive48167130002
    GASH, Michael Alfred
    54 Richmond Hill Road
    Edgbaston
    B15 3AZ Birmingham
    Geschäftsführer
    54 Richmond Hill Road
    Edgbaston
    B15 3AZ Birmingham
    BritishFinancial Director6255580001
    GEOGHEGAN, Christopher Vincent
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector71036100002
    GILROY, John Anthony
    Hollies Boreley House
    Boreley Lane Ombersley
    WR9 0HU Droitwich
    Worcs
    Geschäftsführer
    Hollies Boreley House
    Boreley Lane Ombersley
    WR9 0HU Droitwich
    Worcs
    IrishDirector51549340001
    HENWOOD, Stephen Hugh
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant118342160004
    KIMBERLEY, Howard Fraser
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    BritishFinance Director75325410003
    PALMER, Jonathan
    31 Lime Tree Bay
    Smb
    FOREIGN Grand Cayman
    Cayman Islands
    B W I
    Geschäftsführer
    31 Lime Tree Bay
    Smb
    FOREIGN Grand Cayman
    Cayman Islands
    B W I
    BritishDirector84705470002
    PROBERT, David Henry
    4 Blakes Field Drive
    Barnt Green
    B45 8JT Birmingham
    Geschäftsführer
    4 Blakes Field Drive
    Barnt Green
    B45 8JT Birmingham
    BritishCompany Director1776640001
    SILK, John Geoffrey
    Cranford Thicknall Lane
    Clent
    DY9 0HR Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Cranford Thicknall Lane
    Clent
    DY9 0HR Stourbridge
    West Midlands
    BritishSolicitor13267790001
    SIMON, Andrew Henry
    Thark 29 St Johns Road
    ST17 9AP Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Thark 29 St Johns Road
    ST17 9AP Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director64444330001
    STOKELL, Robert
    Kimbers 6 Wheatfield Avenue
    West Common
    AL5 2NU Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Kimbers 6 Wheatfield Avenue
    West Common
    AL5 2NU Harpenden
    Hertfordshire
    BritishNon Executive Director50304180002
    WALKER, Ian Rodway
    Silverdale Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Silverdale Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector1454400001
    WARD, Kim Stephen
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Waterfront West
    DY5 1LN Brierley Hill
    7 Harbour Buildings
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive71325320006
    WARDLE, John Malcolm
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    BritishSolicitor5096040001
    WAY, Raymond Brinsley Mallen
    Pinners
    Astley
    DY13 0RJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Pinners
    Astley
    DY13 0RJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector14538110001
    WRONSKI, Brian
    47 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    47 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector89156520001

    Hat HAMPSON INDUSTRIES P.L.C. Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Mai 2008
    Geliefert am 13. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 13. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Aug. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Feb. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 and 2 priorswood place pimbo skelmersdale t/no LA776517,3 priorwood place pimbo skelmersdale t/no la 800047,4 priorswood place east pimbo skelmersdale t/no LA766494 (for further details of property charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008
    • 21. Aug. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Aug. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Feb. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Pledge amendment agreement
    Erstellt am 10. Jan. 2007
    Geliefert am 19. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The entire issued share capital of composites horizons, inc. Being 1625 shares.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC the Security Trustee
    Transaktionen
    • 19. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 19. Dez. 2005
    Geliefert am 05. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledged shares and all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2005
    Geliefert am 22. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    T/N MS352498, t/n MS352492, t/n MS265096 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed charge all plant machinery vehicles computers office and other equipment all bank accounts receivables investments intellectual property goodwill uncalled capital floating charge undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    129 scudamore road, leicester t/n LT62073, unit 9, kinwarton farm road and unit 19A kinwarton farm road, arden forest industrial estate, alcester, warwickshire t/n's WK331715 and WK346143 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 17. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest present and future in the policy number RNF00089426A dated 5TH september 2000 with royal and sun alliance unit trust management limited in the name of mark a abbey for 33 years and for the sum of £500,000.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 28TH january 2003 with standard life assurance company policy number X74642651 for 5 years and for the assured sum of £500,000.00 all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right, title and interest present and future in the policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 24TH april 2001 with royal and sun alliance unit trust management limited policy number 0305951197/002 for 35 years and for the assured sum of £500,000.00 for howard f kimberley all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right, title and interest present and future in the policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 25TH january 2001 with royal and sun alliance unit trust management limited policy number 0305951197/001 for 26 years and for the assured sum of £1,000,000.00 of kim S. ward all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right, title and interest present and future in the policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 129 scudamore road leicester LE3 1UQ t/n LT62073UNIT 9 kinwarton farm road and unit 19AKINWARTON farm road arden forest industrial estate alcester warwickshire B49 6EH t/no.s WK331715 and WK346143 4 south bridge industrial estate southall middlesex UB2 4BY t/n NGL636718 for further details of the property charged please refer. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 11. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property occupied by hampson aerospace machining 129 scudamore road leicester LE3 1UQ title number LT62073. Hampson aerospace machining unit 9 kinwarton farm road title number WK331715 unit 19 kinwarton arden forest industrial estate alcester warwickshire B49 6EH title number WK346143. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 11. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1998
    Geliefert am 10. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the south east of shakespeares street southport merseyside t/n MS378536.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1998
    Geliefert am 10. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of duke street southport merseyside t/n MS386120.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1997
    Geliefert am 12. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at rowleys green lane and judds lane coventry west midlands forming part t/n WM258544 and land on the east side of rowleys green lane longford west midlands t/n WM362505.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1997
    Geliefert am 12. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at bilston lane willenhall west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1997
    Geliefert am 12. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of leigh road bolton greater manchester t/n GM348053.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Apr. 1996
    Geliefert am 16. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 3, tunbridge wells business park longfield road tunbridge wells kent t/no. K674923.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 1995
    Geliefert am 30. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4 priorswood place east pimbo skelmersdale lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juni 1995
    Geliefert am 27. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 3 spa industrial park longfield tunbridge wells kent t/no K273701.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    25 scotts road, bromley, l/b of bromley t/n K33097.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 1993
    Geliefert am 04. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property situate in and k/a 84A and 86A shakespeare street southport merseyside.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HAMPSON INDUSTRIES P.L.C. Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Nov. 2012Beginn der Verwaltung
    13. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Chad Griffin
    Midtown 322 High Holborn
    WC1V 7PB London
    Praktiker
    Midtown 322 High Holborn
    WC1V 7PB London
    Simon Kirkhope
    322 High Holborn
    WC1V 7PB London
    Praktiker
    322 High Holborn
    WC1V 7PB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0