LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED

LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00632465
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1020 Eskdale Road Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 23. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET England zum 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS am 30. Aug. 2018

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 03. Aug. 2018

    LRESSP

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman am 31. Jan. 2018

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Matthew James Torode als Direktor am 16. Feb. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Leonard Grose als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Hermes Secretariat Limited als Sekretär am 31. Jan. 2018

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Mepc Secretaries Limited als Sekretär am 31. Jan. 2018

    1 SeitenTM02

    Change of details for Mepc (1946) Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018

    2 SeitenPSC05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ zum Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET am 31. Jan. 2018

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Emily Ann Mousley als Geschäftsführer am 30. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman als Direktor am 23. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 11. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 350,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 350,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Leonard Grose am 29. Jan. 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HERMES SECRETARIAT LIMITED
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03717842
    93700910001
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    Geschäftsführer
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003
    CAINES, Geoffrey Harold
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    Sekretär
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    British22701030002
    PRICE, John Dewi Brychan
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    Sekretär
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    British3041640002
    MEPC SECRETARIES LIMITED
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    4th Floor
    Sekretär
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    4th Floor
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4290683
    79708020003
    BARWICK, Charles Julian
    8 Belgrave Road
    SW13 9NS London
    Geschäftsführer
    8 Belgrave Road
    SW13 9NS London
    EnglandBritishChartered Surveyor3818640001
    BATEMAN, John Anthony
    Hurst House
    Lincombe Lane Boars Hill
    OX1 5DZ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Hurst House
    Lincombe Lane Boars Hill
    OX1 5DZ Oxford
    Oxfordshire
    BritishChartered Surveyor69753820002
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector Taxation100504300001
    CAINES, Geoffrey Harold
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant22701030002
    COURTAULD, Toby Augustine
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    Geschäftsführer
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    BritishChartered Surveyor46882260003
    DIBLEY, Hugh Leslie Stewart
    Morrisdown
    Piltdown
    TN22 3XU Uckfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Morrisdown
    Piltdown
    TN22 3XU Uckfield
    East Sussex
    BritishChartered Surveyor2012160001
    DUNN, Peter Harold
    10 High Street
    TW12 2SJ Hampton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    10 High Street
    TW12 2SJ Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritishRetired629830001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Geschäftsführer
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant108586450001
    EXLEY, Richard John
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    BritishChartered Surveyor50191130002
    GROSE, David Leonard
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishAccountant120479020004
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Surveyor33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    38 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    38 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant93017010003
    MCGARRITY, Stewart
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant65801380001
    MONIZ, Christopher Mario
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritishCertified Accountant3831690001
    MOUSLEY, Emily Ann
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    Geschäftsführer
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    EnglandBritishChartered Accountant155262770003
    PERRY, Albert Richard
    Gatcombe Chase Arrowsmith Road
    Canford Magna
    BH21 3BD Wimborne
    Dorset
    Geschäftsführer
    Gatcombe Chase Arrowsmith Road
    Canford Magna
    BH21 3BD Wimborne
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director2012170001
    PIERCE, Graham Charles
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    Geschäftsführer
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    United KingdomUkAccountant123665160001
    STRATTON, Carol Ann
    127 Maidstone Road
    Ruxley Corner Foots Cray
    DA14 5HX Sidcup
    Kent
    Geschäftsführer
    127 Maidstone Road
    Ruxley Corner Foots Cray
    DA14 5HX Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCompany Secretary79680570001
    THOMPSON, Nathan James
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    Geschäftsführer
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    BritishChartered Surveyor43320980004
    TORODE, Matthew James, Mr.
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    Geschäftsführer
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    EnglandBritishAccountant196412900002
    TUCKER, Louis Newton
    Bearehurst
    Holmwood
    RH5 4LR Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bearehurst
    Holmwood
    RH5 4LR Dorking
    Surrey
    BritishSolicitor37042480001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant4779170003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mepc (1946) Limited
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    06. Apr. 2016
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer00420575
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second supplemental trust deed
    Erstellt am 13. Okt. 2000
    Geliefert am 16. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee £30, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 14 september 1982 and £70, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a supplemental trust deed dated 12 january 1984
    Kurze Angaben
    F/H property at chineham business park chineham basingstoke hampshire t/n HP316566 HP397816 HP317682 HP173001 HP498388 HP423354 HP317683 NGL278770 with all buildings fixtures and benefit of all agreements under the trust deed.
    Berechtigte Personen
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Apr. 1997
    Geliefert am 02. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Friarsgate monks path solihull west midlands t/n wm 622993.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 25. März 1997
    Geliefert am 04. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Kurze Angaben
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a land and buildings on the south side of pen-y-ball street holywell t/n WA350272. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 25. März 1997
    Geliefert am 04. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Kurze Angaben
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a the f/h land and buildings on the south side of wheelock street middlewich t/n CH287780. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 25. März 1997
    Geliefert am 04. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Kurze Angaben
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a land and buildings on the south side of new road willenhall t/n WN423682. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 1995
    Geliefert am 14. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal interest and all other monies due or to become due from psit PLC and/or louisville investments limited to the chargee under the terms of the legal charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit J1 tyne tunnel trading estate tyne and wear north tyneside.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 07. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from psit PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit S3 tyne tunnel trading estate north tyneside tyne & wear t/no.TY106207 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 1995
    Geliefert am 30. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Houndmills industrial estate, basingstoke, hampshire t/no HP491798.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 1992
    Geliefert am 20. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to beome due from property security investment trust PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units D1 and D3 hanover business park altrincham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 21. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings to the south of wheelock street, middlewich t/no: ch 287780 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 21. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south side of new road, willenhall t/no: WM423682(see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 21. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at pen-y-ball street, hollywell, clwyd t/no: wa 350272 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 1988
    Geliefert am 26. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from property securiey investments trust PLC under the terms of the facility agreements dated 18TH august 1983 and the charge to the charger
    Kurze Angaben
    F/Hold piece or parcel of land situate in warwickshire in the district of rugby being land & buildings on the east and west side of consul rd t/n wk 234723 together with the terms covenants etc of the schedule of leases annexed see doc M15 for fuller details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1988
    Geliefert am 25. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Kurze Angaben
    All that part of the land and buildings lying to the south of wheelock st.middlewich t/n ch 271714. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • First Interstate Bank of California
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1988
    Geliefert am 25. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as land & buildings on the south side of pen-y-bal street, holywell t/n wa 350272 see doc M3 for fuller details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • First Interstate Bank of California
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1988
    Geliefert am 25. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Kurze Angaben
    Part of the land & buildings on the south side of new rd willenhall t/n wa 387476 see doc M2 for fuller details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • First Interstate Bank of California
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juni 1986
    Geliefert am 20. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises at crockford lane basingstoke, hants. See doc M145 (now or shortly to be known as clyneham business park, crockford lane (aforesaid).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 1986Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on the 29TH may 1986.
    Erstellt am 29. Mai 1986
    Geliefert am 06. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneis due or to become due from property security investment trust PLC to the chargee.
    Kurze Angaben
    The buildings comprising supermarket premises known as 140/142 arbroath road, dundee, angus & tayside region with grounds & rights pertaining thereto.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over securities
    Erstellt am 18. Juni 1985
    Geliefert am 28. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee dated 18/6/85 or any agreement relating thereto and the charge
    Kurze Angaben
    £1,000,000 by nominal amount of treasury 9% stock 1992/96 and all dividends or interest (full details see doc M143).
    Berechtigte Personen
    • First Interstate Bank of California
    Transaktionen
    • 28. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1985
    Geliefert am 07. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings known as units B1,B3 C8, D1, D2, D3, D4 & D6 situate at M62 trading estate rawcliffe road goole together with all buildings and any thereon and developments now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Grindlays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 1985
    Geliefert am 25. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land & buildings lying to the west of springhead road, northfleet being within the north west kent enterprise zone no.1, Springhead enterprise park, springhead road, northfleet kent t/n k 568656 together with all buildings and and any thereon developments now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Grindlays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1985Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1984
    Geliefert am 14. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situate to the s w of holt way, holt park adel leeds 16 together with the supermarket 16 shop units and office premises erected thereon or on some part thereof all of which is known as holt park centre, add t/ns wyk 184409 &wyk 199914.
    Berechtigte Personen
    • Grindlays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 19. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorondum & deposit of deeds and documents
    Erstellt am 26. Jan. 1984
    Geliefert am 30. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the property security investment trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H land at hyde green pucklechurch margotsfield in the county of gloucestershire.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 1983
    Geliefert am 27. Sept. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 8/aug/83
    Kurze Angaben
    £750,000 of 10 1/2% treasury stock 1999 together with all income interest & dividends paid or payable after the date hereof on any of the above & all stocks shares securities rights money or property (see doc M137 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1983Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1983
    Geliefert am 24. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from property security investment trust PLC under the terms of a loan agreement dated 18/8/83 to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H phase iii of the milton keynes development corporations bradwell abbey employment area milton keynes buckinghamshire. (Approx 2.76 acres).
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Aug. 2018Beginn der Liquidation
    01. Nov. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0