LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00632465 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 23. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET England zum 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS am 30. Aug. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew James Torode als Direktor am 16. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Leonard Grose als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Hermes Secretariat Limited als Sekretär am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mepc Secretaries Limited als Sekretär am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Change of details for Mepc (1946) Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ zum Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emily Ann Mousley als Geschäftsführer am 30. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman als Direktor am 23. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Leonard Grose am 29. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Cheapside EC2V 6ET London Sixth Floor, 150 England |
| 93700910001 | ||||||||||
WILMAN, Kirsty Ann-Marie | Geschäftsführer | Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 Eskdale Road | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 155163600003 | ||||||||
CAINES, Geoffrey Harold | Sekretär | Bindon 48 Hartley Old Road CR8 4HG Purley Surrey | British | 22701030002 | ||||||||||
PRICE, John Dewi Brychan | Sekretär | 12 The Rise RH16 2TA Lindfield West Sussex | British | 3041640002 | ||||||||||
MEPC SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8HZ London 4th Floor |
| 79708020003 | ||||||||||
BARWICK, Charles Julian | Geschäftsführer | 8 Belgrave Road SW13 9NS London | England | British | Chartered Surveyor | 3818640001 | ||||||||
BATEMAN, John Anthony | Geschäftsführer | Hurst House Lincombe Lane Boars Hill OX1 5DZ Oxford Oxfordshire | British | Chartered Surveyor | 69753820002 | |||||||||
BRADY, James Michael | Geschäftsführer | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 3769730001 | ||||||||
BURROWES, David William | Geschäftsführer | 60 Westwater Way OX11 7TY Didcot Oxfordshire | United Kingdom | British | Director Taxation | 100504300001 | ||||||||
CAINES, Geoffrey Harold | Geschäftsführer | Bindon 48 Hartley Old Road CR8 4HG Purley Surrey | England | British | Chartered Accountant | 22701030002 | ||||||||
COURTAULD, Toby Augustine | Geschäftsführer | 45a Moreton Street SW1V 2NY London | British | Chartered Surveyor | 46882260003 | |||||||||
DIBLEY, Hugh Leslie Stewart | Geschäftsführer | Morrisdown Piltdown TN22 3XU Uckfield East Sussex | British | Chartered Surveyor | 2012160001 | |||||||||
DUNN, Peter Harold | Geschäftsführer | 10 High Street TW12 2SJ Hampton Middlesex | United Kingdom | British | Retired | 629830001 | ||||||||
EAST, Stephen John | Geschäftsführer | White Ladies Birch Hill Shirley Hills CR0 5HT Surrey | England | British | Chartered Accountant | 108586450001 | ||||||||
EXLEY, Richard John | Geschäftsführer | Clematis Cottage Turners Green Lane TN5 6TS Wadhurst East Sussex | British | Chartered Surveyor | 50191130002 | |||||||||
GROSE, David Leonard | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6ET London Sixth Floor, 150 England | United Kingdom | British | Accountant | 120479020004 | ||||||||
HARROLD, Richard Anthony | Geschäftsführer | Hill House Farm Brandon Parva NR9 4DL Norwich Norfolk | British | Chartered Surveyor | 33048780001 | |||||||||
LEWIS, Gavin Andrew | Geschäftsführer | 38 Victoria Avenue KT6 5DW Surbiton Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 93017010003 | ||||||||
MCGARRITY, Stewart | Geschäftsführer | Clearwell Cottage Boulters Lane SL6 8TJ Maidenhead Berkshire | British | Chartered Accountant | 65801380001 | |||||||||
MONIZ, Christopher Mario | Geschäftsführer | 26 The Avenue CR5 2BN Coulsdon Surrey | England | British | Certified Accountant | 3831690001 | ||||||||
MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers | England | British | Chartered Accountant | 155262770003 | ||||||||
PERRY, Albert Richard | Geschäftsführer | Gatcombe Chase Arrowsmith Road Canford Magna BH21 3BD Wimborne Dorset | England | British | Company Director | 2012170001 | ||||||||
PIERCE, Graham Charles | Geschäftsführer | 66 Lausanne Road SE15 2JB London | United Kingdom | Uk | Accountant | 123665160001 | ||||||||
STRATTON, Carol Ann | Geschäftsführer | 127 Maidstone Road Ruxley Corner Foots Cray DA14 5HX Sidcup Kent | United Kingdom | British | Company Secretary | 79680570001 | ||||||||
THOMPSON, Nathan James | Geschäftsführer | No 1 Elsynge Road Wandsworth SW18 2HW London | British | Chartered Surveyor | 43320980004 | |||||||||
TORODE, Matthew James, Mr. | Geschäftsführer | Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 Eskdale Road | England | British | Accountant | 196412900002 | ||||||||
TUCKER, Louis Newton | Geschäftsführer | Bearehurst Holmwood RH5 4LR Dorking Surrey | British | Solicitor | 37042480001 | |||||||||
WARE, Robert Thomas Ernest | Geschäftsführer | Woodley Lodge Duffield Road RG5 4RL Woodley Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4779170003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mepc (1946) Limited | 06. Apr. 2016 | Cheapside EC2V 6ET London Sixth Floor, 150 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Second supplemental trust deed | Erstellt am 13. Okt. 2000 Geliefert am 16. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee £30, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 14 september 1982 and £70, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a supplemental trust deed dated 12 january 1984 | |
Kurze Angaben F/H property at chineham business park chineham basingstoke hampshire t/n HP316566 HP397816 HP317682 HP173001 HP498388 HP423354 HP317683 NGL278770 with all buildings fixtures and benefit of all agreements under the trust deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Apr. 1997 Geliefert am 02. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Friarsgate monks path solihull west midlands t/n wm 622993. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of confirmation | Erstellt am 25. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith | |
Kurze Angaben By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a land and buildings on the south side of pen-y-ball street holywell t/n WA350272. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of confirmation | Erstellt am 25. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith | |
Kurze Angaben By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a the f/h land and buildings on the south side of wheelock street middlewich t/n CH287780. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of confirmation | Erstellt am 25. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith | |
Kurze Angaben By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a land and buildings on the south side of new road willenhall t/n WN423682. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Aug. 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal interest and all other monies due or to become due from psit PLC and/or louisville investments limited to the chargee under the terms of the legal charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit J1 tyne tunnel trading estate tyne and wear north tyneside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third party legal charge | Erstellt am 07. Aug. 1995 Geliefert am 24. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from psit PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit S3 tyne tunnel trading estate north tyneside tyne & wear t/no.TY106207 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. März 1995 Geliefert am 30. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Houndmills industrial estate, basingstoke, hampshire t/no HP491798. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Nov. 1992 Geliefert am 20. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to beome due from property security investment trust PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units D1 and D3 hanover business park altrincham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1992 Geliefert am 21. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date | |
Kurze Angaben F/H land and buildings to the south of wheelock street, middlewich t/no: ch 287780 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1992 Geliefert am 21. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south side of new road, willenhall t/no: WM423682(see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1992 Geliefert am 21. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date | |
Kurze Angaben F/H land and buildings at pen-y-ball street, hollywell, clwyd t/no: wa 350272 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Jan. 1988 Geliefert am 26. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from property securiey investments trust PLC under the terms of the facility agreements dated 18TH august 1983 and the charge to the charger | |
Kurze Angaben F/Hold piece or parcel of land situate in warwickshire in the district of rugby being land & buildings on the east and west side of consul rd t/n wk 234723 together with the terms covenants etc of the schedule of leases annexed see doc M15 for fuller details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
First legal charge | Erstellt am 11. Jan. 1988 Geliefert am 25. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985 | |
Kurze Angaben All that part of the land and buildings lying to the south of wheelock st.middlewich t/n ch 271714. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
First legal charge | Erstellt am 11. Jan. 1988 Geliefert am 25. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985 | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as land & buildings on the south side of pen-y-bal street, holywell t/n wa 350272 see doc M3 for fuller details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
First legal charge | Erstellt am 11. Jan. 1988 Geliefert am 25. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985 | |
Kurze Angaben Part of the land & buildings on the south side of new rd willenhall t/n wa 387476 see doc M2 for fuller details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Juni 1986 Geliefert am 20. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises at crockford lane basingstoke, hants. See doc M145 (now or shortly to be known as clyneham business park, crockford lane (aforesaid). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security presented for registration in scotland on the 29TH may 1986. | Erstellt am 29. Mai 1986 Geliefert am 06. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneis due or to become due from property security investment trust PLC to the chargee. | |
Kurze Angaben The buildings comprising supermarket premises known as 140/142 arbroath road, dundee, angus & tayside region with grounds & rights pertaining thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over securities | Erstellt am 18. Juni 1985 Geliefert am 28. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee dated 18/6/85 or any agreement relating thereto and the charge | |
Kurze Angaben £1,000,000 by nominal amount of treasury 9% stock 1992/96 and all dividends or interest (full details see doc M143). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1985 Geliefert am 07. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings known as units B1,B3 C8, D1, D2, D3, D4 & D6 situate at M62 trading estate rawcliffe road goole together with all buildings and any thereon and developments now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. März 1985 Geliefert am 25. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land & buildings lying to the west of springhead road, northfleet being within the north west kent enterprise zone no.1, Springhead enterprise park, springhead road, northfleet kent t/n k 568656 together with all buildings and and any thereon developments now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1984 Geliefert am 14. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land situate to the s w of holt way, holt park adel leeds 16 together with the supermarket 16 shop units and office premises erected thereon or on some part thereof all of which is known as holt park centre, add t/ns wyk 184409 &wyk 199914. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorondum & deposit of deeds and documents | Erstellt am 26. Jan. 1984 Geliefert am 30. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the property security investment trust PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H land at hyde green pucklechurch margotsfield in the county of gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 1983 Geliefert am 27. Sept. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 8/aug/83 | |
Kurze Angaben £750,000 of 10 1/2% treasury stock 1999 together with all income interest & dividends paid or payable after the date hereof on any of the above & all stocks shares securities rights money or property (see doc M137 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Aug. 1983 Geliefert am 24. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from property security investment trust PLC under the terms of a loan agreement dated 18/8/83 to the chargee | |
Kurze Angaben F/H phase iii of the milton keynes development corporations bradwell abbey employment area milton keynes buckinghamshire. (Approx 2.76 acres). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0