HMV CARD SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HMV CARD SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00635858 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HMV CARD SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Windsor House Spittal Street SL7 3HJ Marlow Buckinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HMV SHOPS LIMITED | 12. Mai 1986 | 12. Mai 1986 |
| RADIO RENTALS THAMESDOWN CABLE LIMITED | 17. Juni 1983 | 17. Juni 1983 |
| CLEARVISION,LIMITED | 27. Aug. 1959 | 27. Aug. 1959 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Apr. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Peter Kenyon als Geschäftsführer am 31. Jan. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Philip Moore als Geschäftsführer am 08. Feb. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elaine Marriner als Geschäftsführer am 24. Jan. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elaine Marriner als Sekretär am 24. Jan. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Peter Kenyon als Direktor am 03. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Trevor Philip Moore als Direktor am 03. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Richard Fox als Geschäftsführer am 03. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Apr. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR am 13. März 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Bright als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Apr. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Elaine Marriner am 10. Mai 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Richard Fox am 10. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Elaine Marriner am 10. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Neil Irvine Bright am 10. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Apr. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHT, Neil Irvine | Sekretär | Pound End Cedar Drive, Cookham SL6 9DZ Maidenhead Berkshire | British | 180993450001 | ||||||
| CAMPBELL, Laurence James | Sekretär | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Sekretär | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Sekretär | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | British | 76768320001 | ||||||
| MARRINER, Elaine | Sekretär | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | British | 40470020001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Sekretär | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SMITH, George Marsden | Sekretär | 18 Bevin Square SW17 7BB London | British | 15729150003 | ||||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Sekretär | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | British | 63502600001 | ||||||
| BELL, Duncan Charles | Geschäftsführer | Longwood Queen Annes Road SL4 2BJ Windsor Berkshire | British | 9950440002 | ||||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Geschäftsführer | Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead SL6 1SR Berkshire | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| FOX, Simon Richard | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||
| GILES, Alan James | Geschäftsführer | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Geschäftsführer | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| KENYON, Ian Peter | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 107735600001 | |||||
| LYMATH, Michael Gerald | Geschäftsführer | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | England | British | 76768320001 | |||||
| MARRINER, Elaine | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 40470020001 | |||||
| MCALLISTER, Stuart | Geschäftsführer | The Granary 38 Wellington Street OX9 3BN Thame Oxfordshire | British | 9406880001 | ||||||
| MOORE, Trevor Philip | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 113047410001 | |||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Geschäftsführer | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 63502600001 |
Hat HMV CARD SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 04. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998) | Erstellt am 14. Mai 1998 Geliefert am 15. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities | |
Kurze Angaben By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0