WMC RETAIL PARTNERS PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWMC RETAIL PARTNERS PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00636475
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor Cavendish House 39-41 Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WELLINGTON MARKET COMPANY PLC08. Mai 199608. Mai 1996
    WELLINGTON MARKET & PROPERTY CO PLC16. Juni 199516. Juni 1995
    WELLINGTON (SALOP) MARKETS COMPANY LIMITED04. Sept. 195904. Sept. 1959

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    31 SeitenAM23

    Kündigung eines Administrators

    5 SeitenAM15

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    31 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row Birmingham B3 2BB zum 3rd Floor Cavendish House 39-41 Waterloo Street Birmingham B2 5PP am 13. Apr. 2021

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    32 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOC

    7 SeitenAM02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenAM06

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    19 SeitenCVA4

    Vorschlag des Verwalters

    77 SeitenAM03

    Ernennung eines Verwalters

    4 SeitenAM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 21 Market Street Wellington Telford Shropshire TF1 1DT zum Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row Birmingham B3 2BB am 16. Aug. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Nigel James Higgs als Direktor am 20. Mai 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Lord Lee of Trafford als Geschäftsführer am 10. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Chadwick als Geschäftsführer am 10. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    7 SeitenCVA1

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Joseph Kenneth Michael Riley als Sekretär am 24. Nov. 2017

    1 SeitenTM02

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    52 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Malcolm Phillip Ball als Geschäftsführer am 29. Aug. 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEWETT, Sarah Jeanette
    Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    3rd Floor Cavendish House 39-41
    Geschäftsführer
    Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    3rd Floor Cavendish House 39-41
    United KingdomBritishBanker112314050001
    HIGGS, Nigel James
    Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    3rd Floor Cavendish House 39-41
    Geschäftsführer
    Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    3rd Floor Cavendish House 39-41
    EnglandBritishAccountant90670810001
    SPARROW, Andrew Brian
    Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    3rd Floor Cavendish House 39-41
    Geschäftsführer
    Waterloo Street
    B2 5PP Birmingham
    3rd Floor Cavendish House 39-41
    EnglandBritishCompany Director189568870001
    DAVIES, John Leslie
    9 Golf Links Lane
    Wellington
    TF1 2DT Telford
    Shropshire
    Sekretär
    9 Golf Links Lane
    Wellington
    TF1 2DT Telford
    Shropshire
    British32948940001
    FICE, Paul Hugh
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    Sekretär
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    British72093060001
    RILEY, Joseph Kenneth Michael
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    Sekretär
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    211719820001
    SMITH, Peter Neville
    Westwinds Barnfield
    Birch More Lane Edgmond
    TF10 8LA Newport
    Shropshire
    Sekretär
    Westwinds Barnfield
    Birch More Lane Edgmond
    TF10 8LA Newport
    Shropshire
    British49634560001
    TOWLER, Jonathan David
    Oakfield
    Beddoes Drive Bayston Hill
    SY3 OBU Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    Oakfield
    Beddoes Drive Bayston Hill
    SY3 OBU Shrewsbury
    Shropshire
    BritishChartered Surveyor34605800001
    BALL, Malcolm Phillip
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishChief Executive131057930002
    BARBER, Christopher John
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    EnglandBritishAccountant80426920001
    BURNETT, Andrew
    4 Mayfair Grove
    Priorslee
    TF2 9GJ Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    4 Mayfair Grove
    Priorslee
    TF2 9GJ Telford
    Salop
    BritishChief Executive69315790001
    CHADWICK, Michael
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    IrelandIrishDirector16417710002
    DAVIES, John Leslie
    The Croft
    5 Carvers Croft
    SY13 6PJ Much Wenlock
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Croft
    5 Carvers Croft
    SY13 6PJ Much Wenlock
    Shropshire
    BritishAccountant32948940002
    DAVIES, John Leslie
    9 Golf Links Lane
    Wellington
    TF1 2DT Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    9 Golf Links Lane
    Wellington
    TF1 2DT Telford
    Shropshire
    BritishAccountant32948940001
    FITZPATRICK, Alan Roy
    Far Leys House
    Bates Lane
    B94 5AP Tanworth In Arden
    Solihull Warwks
    Geschäftsführer
    Far Leys House
    Bates Lane
    B94 5AP Tanworth In Arden
    Solihull Warwks
    EnglandBritishCompany Director15096000001
    GOLDSMITH, Christopher Charles
    Cobb Court
    Selmeston
    BN26 6TS Polegate
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Cobb Court
    Selmeston
    BN26 6TS Polegate
    East Sussex
    BritishChartered Accountant23433810004
    JONES, Thomas William
    Grangelands
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    Salop
    Geschäftsführer
    Grangelands
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    Salop
    BritishRetired Farmer14006090001
    LANYON, David Hugh
    31 Albert Road
    Wellington
    TF1 3AR Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    31 Albert Road
    Wellington
    TF1 3AR Telford
    Salop
    BritishSolicitor14006080001
    LINSLEY, Peter William
    86 Haygate Road
    Wellington
    TF1 2BJ Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    86 Haygate Road
    Wellington
    TF1 2BJ Telford
    Shropshire
    BritishOperations Management84574000001
    LORD LEE OF TRAFFORD, John
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    21 Market Street
    Wellington
    TF1 1DT Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishPeer Of The Realm113358390001
    ROSS, Peter Francis
    Earlswood 11 Ercall Lane
    TF1 2DY Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    Earlswood 11 Ercall Lane
    TF1 2DY Telford
    Salop
    BritishChartered Accountant12540370001
    SIMON, Geoffrey Michael
    The Manor House
    Aston Magna
    GL56 9QQ Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Aston Magna
    GL56 9QQ Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishSolicitor35520060001
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Geschäftsführer
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritishStorage Operator32981540001
    TOWLER, Jonathan David
    Oakfield
    Beddoes Drive Bayston Hill
    SY3 OBU Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Oakfield
    Beddoes Drive Bayston Hill
    SY3 OBU Shrewsbury
    Shropshire
    BritishChartered Surveyor34605800001
    WREFORD, Roger John
    The Clergy House
    Marlston
    RG18 9UP Thatcham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Clergy House
    Marlston
    RG18 9UP Thatcham
    Berkshire
    BritishChartered Accountant8288340003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WMC RETAIL PARTNERS PLC?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    5 Bank Street
    BL9 0DN Bury
    The Exchange
    England
    06. Apr. 2016
    5 Bank Street
    BL9 0DN Bury
    The Exchange
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02068819
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat WMC RETAIL PARTNERS PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. Okt. 2016
    Geliefert am 24. Okt. 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Dlmi Company (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 25. Mai 2010
    Geliefert am 28. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2010
    Geliefert am 28. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cornish market world stadium retail park great mills industrial parc par moor road st austell cornwall t/no CL230451 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 25. Mai 2010
    Geliefert am 28. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 20. März 2006
    Geliefert am 23. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a morley market queen street morley leeds t/n wyk 597106. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 07. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being cleethorpes indoor market 219 north promenade cleethorpes. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 45 commercial street, morley, t/no WYK251485 by way of first fixed charge all plant, machinery and equipment, all its rights under or in connection with any contracts or policies of insurance.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge with floating charge
    Erstellt am 24. Juli 2001
    Geliefert am 26. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan facility agreement (as defined) or the deed
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at morley market hope street morley leeds WYK597106 all plant and machiner all insurances and a floating charge all other assets.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 26. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 21. März 2000
    Geliefert am 24. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as land and buildings at wellington market, wellington t/n SL96902. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land south of mill lane selsey west sussex t/n wsx 197474. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at heil bronn way port talbot west glamorgan t/n wa 539405. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at station road treorchy rhondda t/n WA749367. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land & buildings to the south east of merthyr houses clydach river tawer clydach west glamorgan t/n wa 297196. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land & building to the south east of merthyr houses clydach river tawe clydach west glamorgan t/n WA659777. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 26/30 surrey street littlehampton west sussex t/n WSX38404. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 1 high street littlehampton west sussex t/n esx 71550. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 2A high street littlehampton west sussex t/n WSX151623. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land to the west of surrey street littlehampton w sussex t/n wsx 197489. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2A high street littlehampton west sussex t/no WSX151623. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    26/30 surrey street littlehampton west sussex t/no WSX38404. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 high street littlehampton west sussex t/no wsx 71550. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the west of surrey street littlehampton west sussex t/no wsx 197489. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south east of merthyr houses clydach river tawe clydach west glamorgan t/no WA659777. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land south of mill lane selsey west sussex t/no wsx 197474. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings to the south east of merthyr houses clydach river tawe clydach west glamorgan t/no WA297196. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)

    Hat WMC RETAIL PARTNERS PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Aug. 2018Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    22. Aug. 2019Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Masters
    Leonard Curtis Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Praktiker
    Leonard Curtis Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Conrad Alan Beighton
    Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Praktiker
    Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    2
    DatumTyp
    02. Aug. 2019Beginn der Verwaltung
    01. Feb. 2022Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Masters
    Leonard Curtis Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Praktiker
    Leonard Curtis Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Conrad Alan Beighton
    Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Praktiker
    Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    David Craig Griffiths
    Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Praktiker
    Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0