CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00637686 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
- Herstellung anderer chemischer Erzeugnisse n.e.c. (20590) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 217 Walton Summit Road Bamber Bridge PR5 8AQ Preston Lancashire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COMPOUNDING INGREDIENTS LIMITED | 23. Sept. 1959 | 23. Sept. 1959 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box PR5 8AQ 271 Walton Summit Walton Summit Rod Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ England zum 217 Walton Summit Road Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ am 29. Apr. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 27 Riverside Way Uxbridge Middlesex UB8 2YF zum PO Box PR5 8AQ 271 Walton Summit Walton Summit Rod Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ am 27. Apr. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Citco Management Uk Ltd als Sekretär am 28. Juni 2019 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bernd Paul Josef Helfrich als Geschäftsführer am 30. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 13. Nov. 2019 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Birgitt Michaela Nord als Sekretär am 29. März 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Richard Spalton als Geschäftsführer am 30. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Heidi Ann Weiler als Direktor am 20. Okt. 2017 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO MANAGEMENT UK LTD | Sekretär | Albemarle Street W1S 4HQ London 7 United Kingdom |
| 252274080001 | ||||||||||
| HECKMANN, Gert Gunter Werner, Dr | Geschäftsführer | Walton Summit Road Bamber Bridge PR5 8AQ Preston 217 Lancashire United Kingdom | Germany | German | 197800590001 | |||||||||
| WEILER, Heidi Ann, Ms. | Geschäftsführer | Willow Lake Boulevard P.O. Box 64683 St Paul 1200 Minnesota 55164-0683 United States | United States | American | 239047270001 | |||||||||
| ASTLES, Peter Blair | Sekretär | 165 Shaftsbury Avenue Timperley WA15 7AY Altrincham Cheshire | British | 14727110001 | ||||||||||
| NORD, Birgitt Michaela | Sekretär | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | 221512510001 | |||||||||||
| SMART, Iain | Sekretär | 132a Roe Lane PR9 7PJ Southport Merseyside | British | 30605140001 | ||||||||||
| STIRZAKER, Mark Robert | Sekretär | Lower Dunishbooth House Lane Head OL12 6BH Rochdale Lancashire | British | 78366970002 | ||||||||||
| VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED | Sekretär | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England |
| 110906090002 | ||||||||||
| ASH, Arthur Burr | Geschäftsführer | 292 Roosevelt Place Grosse Pointe Michigan 48230 FOREIGN Usa | Usa | 14727120001 | ||||||||||
| ASTLES, Peter Blair | Geschäftsführer | 45 Pall Mall SW1Y 5JG London Times Place | United Kingdom | British | 14727110003 | |||||||||
| ASTLES, Peter Blair | Geschäftsführer | 94 Stockport Road Timperley WA15 7SN Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 14727110003 | |||||||||
| BENAROUS, Aissa | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | Uk | British | 114284480001 | |||||||||
| BENAROUS, Aissa | Geschäftsführer | 11a Trafalgar Road Birkdale PR2 8EA Southport Merseyside | British | 60210410001 | ||||||||||
| BURLEY, Nicholas James | Geschäftsführer | 45 Pall Mall SW1Y 5JG London Times Place | United Kingdom | British | 122799590001 | |||||||||
| CAPPS, Samuel Henderson | Geschäftsführer | 47 Daily Hills Circle Ringgold Georgia 30736 FOREIGN Usa | Usa | 14727140001 | ||||||||||
| COX, Stephen John | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | England | British | 16542850004 | |||||||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Geschäftsführer | Belvedere Lodge 18 Highbury Road Wimbledon Village SW19 7PR London | England | British | 105961550001 | |||||||||
| GOMBERG, Edward Nicholas | Geschäftsführer | 2003 Amnicola Highway Chattanooga 37406 Tennessee Usa | Usa | 14727150004 | ||||||||||
| GOMBERG, Helen Elizabeth | Geschäftsführer | 2003 Amnicola Highway Chattanooga FOREIGN Tennessee 37406 Usa | American | 41936190002 | ||||||||||
| GOMBERG, Jeffrey Gregory | Geschäftsführer | 2003 Amnicola Highway Chattanooga Tennessee 37406 Usa | American | 30605130003 | ||||||||||
| HARRIS, Howard Elliott | Geschäftsführer | 15 Queen's Gate Gardens SW7 5LY London | British | 93378750001 | ||||||||||
| HAY, Nigel Bruce | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | United Kingdom | British | 124316170001 | |||||||||
| HAY, Nigel Bruce | Geschäftsführer | The New Shippen Higher Lane Scorton PR3 1BE Preston Lancashire | United Kingdom | British | 124316170001 | |||||||||
| HELFRICH, Bernd Paul Josef | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | Germany | German | 197801580001 | |||||||||
| MARTIN, Robert Stephen | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | United Kingdom | British | 150864050001 | |||||||||
| MAUNDRELL, Graham Lloyd | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | United Kingdom | British | 56093930002 | |||||||||
| MELTHAM, John David | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | United Kingdom | British | 74570910001 | |||||||||
| MENENDEZ, Joseph Henry | Geschäftsführer | 32 Iverna Gardens W8 6TW London | Usa | American | 127225800001 | |||||||||
| MILLER, Matthew Kerr | Geschäftsführer | Hollins Lane SK6 5DA Marple Bridge 106 Cheshire | United Kingdom | British | 179720330001 | |||||||||
| O'CONNOR, Calvin James John | Geschäftsführer | 10 Moss Lane Timperley WA15 6SZ Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 16253240001 | |||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Geschäftsführer | The Croft House 4 Hawkshill Close KT10 8JY Esher Surrey | United Kingdom | United Kingdom | 116941050001 | |||||||||
| SIMMONDS, Barrie | Geschäftsführer | 60 Fairlands Road BL9 6QB Bury Greater Manchester | British | 60210430001 | ||||||||||
| SMART, Iain | Geschäftsführer | 132a Roe Lane PR9 7PJ Southport Merseyside | British | 30605140001 | ||||||||||
| SPALTON, Charles Richard | Geschäftsführer | Riverside Way UB8 2YF Uxbridge 27 Middlesex | United Kingdom | British | 1786610001 | |||||||||
| WEXLER, Eric Monroe | Geschäftsführer | 523 Fern Trail Signal Mountain Tennessee 37377-3168 Usa | American | 30605120003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommerling Uk Ltd | 06. Apr. 2016 | Riverside Way Cowley UB8 2YF Uxbridge 27 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 08. Aug. 2016 | 13. Nov. 2019 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen gibt, hat diese jedoch nicht identifiziert. |
Hat CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Okt. 2013 Geliefert am 09. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Okt. 2013 Geliefert am 04. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Apr. 2009 Geliefert am 01. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Aug. 2005 Geliefert am 12. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. März 2003 Geliefert am 28. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. März 2003 Geliefert am 28. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property known as 217 walton summit road, walton summit centre, bamber bridge, preston, lancashire, PR5 8AQ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 1982 Geliefert am 09. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H unit 217, walton summit centre, bamber bridge. Preston, lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on a building agreement | Erstellt am 06. Apr. 1979 Geliefert am 24. Apr. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the interest of the company in a building agreement 10.1.79 between central lancashire new town development corporation & the company relating to unit 217, walton summit centre, bomlier bridge, preston, lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Dez. 1974 Geliefert am 24. Dez. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & bldg. On the northeast side of dearding st, greater manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Aug. 1974 Geliefert am 20. Aug. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 581 lytham road, blackpool. Lancs, together with land forming the site & appointment thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0