ENGLISH PROPERTY CORPORATION
Überblick
| Unternehmensname | ENGLISH PROPERTY CORPORATION |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 00640408 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENGLISH PROPERTY CORPORATION?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ENGLISH PROPERTY CORPORATION?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENGLISH PROPERTY CORPORATION?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ENGLISH PROPERTY CORPORATION LIMITED | 26. Okt. 1959 | 26. Okt. 1959 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENGLISH PROPERTY CORPORATION?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENGLISH PROPERTY CORPORATION?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP zum 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS am 09. Mai 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ zum No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP am 20. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emily Ann Mousley als Geschäftsführer am 30. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman als Direktor am 23. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Leonard Grose am 29. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8LW* am 22. Dez. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Leonard Grose am 20. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alasdair Evans als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENGLISH PROPERTY CORPORATION?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEPC SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 4th Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8LW London |
| 79708020003 | ||||||||||
| GROSE, David Leonard | Geschäftsführer | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 Berkshire | United Kingdom | British | 120479020004 | |||||||||
| WILMAN, Kirsty Ann-Marie | Geschäftsführer | c/o Mepc Secretaries Limited Portsoken Street E1 8HZ London 1 England | England | British | 155163600003 | |||||||||
| LEE, John Philip Macarthur | Sekretär | Flat 9 14 Marylebone Street W1M 7PR London | British | 32509900003 | ||||||||||
| PRATT, Dennis Charles | Sekretär | Firfield 5 Menin Way GU9 8DY Farnham Surrey | British | 3815800001 | ||||||||||
| PRICE, John Dewi Brychan | Sekretär | 12 The Rise RH16 2TA Lindfield West Sussex | British | 3041640002 | ||||||||||
| BATCHELOR, Peter Andrew | Geschäftsführer | Flat 269 North County Hall 1c Belvedere Road SE1 7GF London | British | 68594020002 | ||||||||||
| BEVERIDGE, James Aitchison | Geschäftsführer | 8 La Tourne Gardens BR6 8EJ Orpington Kent | United Kingdom | British | 3037910001 | |||||||||
| BRADY, James Michael | Geschäftsführer | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | England | British | 3769730001 | |||||||||
| BURROWES, David William | Geschäftsführer | 60 Westwater Way OX11 7TY Didcot Oxfordshire | United Kingdom | British | 100504300001 | |||||||||
| EAST, Stephen John | Geschäftsführer | White Ladies Birch Hill Shirley Hills CR0 5HT Surrey | England | British | 108586450001 | |||||||||
| EVANS, Alasdair David | Geschäftsführer | 8 Copsem Lane KT10 9EU Esher Treaton Mill Surrey | United Kingdom | British | 130019430001 | |||||||||
| HARROLD, Richard Anthony | Geschäftsführer | Hill House Farm Brandon Parva NR9 4DL Norwich Norfolk | British | 33048780001 | ||||||||||
| LEWIS, Gavin Andrew | Geschäftsführer | 38 Victoria Avenue KT6 5DW Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 93017010003 | |||||||||
| MCGARRITY, Stewart | Geschäftsführer | Clearwell Cottage Boulters Lane SL6 8TJ Maidenhead Berkshire | British | 65801380001 | ||||||||||
| MONAGHAN, Kevin Peter | Geschäftsführer | Pendennis High Street, Long Wittenham OX14 4QJ Abingdon Oxon | England | British | 116273610001 | |||||||||
| MONIZ, Christopher Mario | Geschäftsführer | 26 The Avenue CR5 2BN Coulsdon Surrey | England | British | 3831690001 | |||||||||
| MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | Flat C, 1 Cranley Gardens, Muswell Hill N10 3AA London | United Kingdom | British | 155262770001 | |||||||||
| SHEPPARD, Colin George | Geschäftsführer | Moffatt Cottage Berry Lane WD3 5EU Chorleywood Hertfordshire | England | British | 213673820001 | |||||||||
| STRATTON, Carol Ann | Geschäftsführer | 127 Maidstone Road Ruxley Corner Foots Cray DA14 5HX Sidcup Kent | England | British | 79680570001 | |||||||||
| THOMPSON, Nathan James | Geschäftsführer | No 1 Elsynge Road Wandsworth SW18 2HW London | British | 43320980004 | ||||||||||
| TUCKEY, James Lane | Geschäftsführer | 95 Elgin Crescent W11 2JF London | United Kingdom | British | 35019240001 | |||||||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Geschäftsführer | Woodley Lodge Duffield Road RG5 4RL Woodley Berkshire | United Kingdom | British | 4779170003 | |||||||||
| WATTERS, Iain Russell | Geschäftsführer | Laurel Bank Poyle Lane SL1 8LA Burnham Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 3717820002 |
Hat ENGLISH PROPERTY CORPORATION Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of release and substitution | Erstellt am 11. Feb. 1997 Geliefert am 17. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on £10,000,000 9 7/8 percent. First mortgage debenture stock 1997/2002 of the company constituted and secured by a trust deed dated 7TH july 1972 made between the company certain subsidiaries of the company and the trustee and by deeds supplemental thereto including the deed of release and substitution above referred to and all other moneys intended to be secured by such trust deed and the deeds supplemental thereto including such deed of release and substitution | |
Kurze Angaben All those premises k/a abbots house abbey street reading t/n BK212357 with all buildings erections fixed plant & machinery landlords fixtures thereon belonging to the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of lease & substitution | Erstellt am 19. Apr. 1988 Geliefert am 21. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000,000 9 7/8 % first mortgage debenture stock 1997/2002 & all other monies due from the company to the chargee secured by a trust deed dated 7/7/72 | |
Kurze Angaben The sum of £1,375,000 forming part of the specific security as defined by the trust deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 07. März 1988 Geliefert am 10. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing the payment of the principal of and interest on the outstanding £20,000,000 9 3/4 % fist mortgage debenture stock 1997/2002 of mepc PLC and all other moneys due from the company to the chargee under the terms of the deed & various other deeds to which it is supplemental as defined in the deed. | |
Kurze Angaben F/H greycoat house, greycoat place, london borough of city of westminister t/n ln 175945 together with all buildings erections, fixed plant fixtuers of fittings and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 30. Okt. 1987 Geliefert am 05. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal sum and all other monies due or to become due from the company to the chargee on the £10,000,000 1ST mortgage debenture stock 1997/2002 created and secured by a trust deed dated 7/7/72 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben All those premises known as petershill house, queen victoria street in teh city of london & all buildings & erections fixed plant machinery & land lands fixtures thereon (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release substituion | Erstellt am 05. Aug. 1986 Geliefert am 13. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10 m 10. 5% first mortgage debenture stock 1983-87 of the company secured by a turst deed dated 17 dec 1970 and all other moneys intended to be secured by deeds supplemental thereto and £5M 15. 75% first mortgage debenture stock 1987 of the company secured by a trsut deed dated 30 dec 1977 and all other moneys intended to be secured by deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben L/Hold property k/as kingsmead shopping centre farnborough, rushmoor hampshire title no hp 235680 l/hold land & buildings lying on the west of kingsmead, farnborough rushmoor hampshire title no hp 179106 together (in the case of both properties) with all buildings fixed plant machinery and fixtures (other than tenant's or trade fixtures) thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Nov. 1982 Geliefert am 11. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the principal deed dated 26/5/81 as varied by the facility letter dated 25/8/81 and amended by the further facilitiy letter dated 31/3/82 | |
Kurze Angaben F/H land at clarence st thames st & bishop's hall kingston upon thames surrey known as bishop's palace house title nos sy 312870 sy 304298 sgl 294623. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben L/H 112,114,116 old street finsbury islington ln 94524 l/h 44 to 52 (even nos) banner st finsbury ln 170668 & ln 237042 with all buildings fixtures legal charge over rents benefit of any proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land in queen street barnstaple in the county of north devon together with the building erected thereon or some part therof and known as princess house, queen street barnstaple. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salimex ag egnach under the terms of an agreement dated 8 july 1982. to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land 417 and 419 sutton road, southend on sea, essex title no ex 235474. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from salimex ag egnach to the chargee under the terms of an agreement dated 8 july 1982 | |
Kurze Angaben F/H land and building in drury lane, macklin street, and parker street holborn london borough of camden title no ngl 36377. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chragee under the terms of an agreement dated 8/7/8I | |
Kurze Angaben L/H known as concord house, 454,456 and 458 london road, croydon, greater london, title no sg 1236755. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben L/H property the beeches, 42 to 68 market place nottingham road long eaton erewash title no dy 53752 with all buildings fixtures etc legal charge over rents bennefit of all proceeds of sale threof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of substituion | Erstellt am 18. Jan. 1982 Geliefert am 02. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever was registered pursuant to section 95 companies act 1948 on the 2/2/82 | |
Kurze Angaben L/H holland house, 120/21, pall mall in the city of westminster registered at H.M. land registry title no 422732 and l/h land at 21, college hill, london registered at H.M. land registry title no ln 86667. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 11. Nov. 1981 Geliefert am 13. Nov. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing £1,025,00072 % first mortgage debenture stock 1992-1997 o fthe company securet by the principal deed deated 13/2/67 and deeds supplemental thereto. | |
Kurze Angaben F/H 44-58 -even nos) charles street, 5,7 & 9A, york street & the sites of 7 & 11, york street, chorlton-on-medlock with the buildings on whole or part thereof known as bracken house, title no. La 6708, f/h 26,26A,26B,26C & 27A fore street and 26, corporatin street, taunton, taunton deane borough council, somerset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Mai 1981 Erworben am 29. Juni 1984 Geliefert am 19. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,000,000 | |
Kurze Angaben Redwell house, bell lane, london E1 title no: ln 77541. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Mai 1981 Erworben am 19. Apr. 1985 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000 | |
Kurze Angaben Market gates shopping centre at yarmouth norfolk title no nk 16118. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Mai 1981 Geliefert am 03. Juni 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H - lee house, london wall, london, EC2 titl eno's ln 222195 & ln 222366 f/h- land in drury lane macklin st, and parker st, holborn, london borough of camden title no ngl 36377. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 07. Mai 1981 Geliefert am 13. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal amount of first mortgage debenture stock 1992/97 & all other monies intended to be secured by a trust deed dated 13.2.67 and deeds supplemetal thetreto | |
Kurze Angaben 48,50, & 51 floral street & passageway between 49 and 50 floral street london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & subsitution | Erstellt am 18. Sept. 1980 Geliefert am 23. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000,000 11 1/2 % first mortgage & debenture stock 1982 of the company secured by a trust deed dated 30/12/77 and supplemental trust deed dated 29/12/78 together with, all interst and other monies thereby secured | |
Kurze Angaben L/H kingsmead centre, phase ii farnborough, hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of guarantee and legal mortgage dated | Erstellt am 15. Aug. 1980 Geliefert am 19. Aug. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the international finance S.A. to international westminster bank limited under the terms of an agreement dated 31/10/73 | |
Kurze Angaben Lee house london wall london EC2 title no ln 222195 and ln 222366. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1980 Geliefert am 01. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 454,456 & 458 london rd croydon, surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 07. März 1980 Geliefert am 10. März 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £1,000,000 6 1/2% 1ST mortgage debenture stock 1978/83 of 2ND covant garden property company LTD and all other monies due under the terms of trust deed dated 22/07/58 and deeds supplemental thereto. | |
Kurze Angaben F/Hold property:-48, 50 and 59 floral street title no ngl 321822. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Feb. 1980 Erworben am 19. Nov. 1979 Geliefert am 07. Feb. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000 | |
Kurze Angaben Property in colyear street & macklin street,derby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Juli 1979 Erworben am 28. Mai 1980 Geliefert am 31. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £711,200 | |
Kurze Angaben 417/419 sutton road southend on sea essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & subsitution | Erstellt am 13. März 1979 Geliefert am 15. Mai 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £10,000,000 9 7/8 first mortgage debenture stock of the company secured by a trust deed dated 7 july 1972 and deeds supplemental thereto. | |
Kurze Angaben All those premises known as crest house and petershill house queen victoria street, london title no ln 240584. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ENGLISH PROPERTY CORPORATION Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0