LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED

LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00640499
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Onslow House
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Essex
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Lb Group als Sekretär am 26. Apr. 2016

    1 SeitenTM02

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    4 SeitenMG02

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Ernennung von Lb Group als Sekretär

    2 SeitenAP04

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2010

    5 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Apr. 2011

    Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2011

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 129 New London Road Chelmsford Essex CM2 0QT* am 23. Feb. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MORGAN, Derek Reginald
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    Sekretär
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    BritishRetired126193150001
    MORGAN, Ryan Francis Kenneth
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Directors116420720002
    PLATT, Ryan Henry John
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director128481590001
    BURNEY, Paula
    Ivy Manor
    44-46 Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    Essex
    Sekretär
    Ivy Manor
    44-46 Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    Essex
    British124430740001
    GREY, Christopher John
    39 Warren Avenue
    TW10 5DZ Richmond
    Surrey
    Sekretär
    39 Warren Avenue
    TW10 5DZ Richmond
    Surrey
    British84361370001
    CR SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    757780001
    LB GROUP
    62
    Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    United Kingdom
    Sekretär
    62
    Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer00640499
    166331740001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Sekretär
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    123667200001
    WH SECRETARIES LIMITED
    Atlas House Fourth Floor
    1 King Street
    EC2V 8AU London
    Sekretär
    Atlas House Fourth Floor
    1 King Street
    EC2V 8AU London
    58494040002
    BURNEY, Daren Mark
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    Geschäftsführer
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    United KingdomBritishDirector102580230005
    SPYROPOULOS, Julie Catherine
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director53062950004
    SPYROPOULOS, Theodore Lycourgos
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    BritishProperty Manager31944200006

    Hat LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    252 and 252A and building plot at the rear of 252 upper richmond road west. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    244 and 244A upper richmond road t/no SY42198. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    49 st peters street canterbury t/no K30204. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    240 and 240A upper richmond road and 135D sheen lane london t/no SY229650.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    159 white hart lane t/no SGL508097. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deposit agreement
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £35,000 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2001
    Geliefert am 06. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A floating charge over the undertaking and all rights properties and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 2001
    Geliefert am 06. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property k/a 49 st pters street canterbury t/n K730204 and 244 upper richmond road east sheen in the london borough of richmond upon thames t/n SY42198 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plan and machinery from time to time on the mortgaged property and the goodwill of any business carried on on the mortgaged property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 2000
    Geliefert am 23. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 236 upper richmond road west east sheen l/b richmond-on-thames.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 02. Nov. 2000
    Geliefert am 10. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juli 1999
    Geliefert am 22. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    159 white hart lane barnes london borugh of richmond upon thames t/n SGL508097.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 1998
    Geliefert am 03. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A floating charge over the undertaking and all rights properties and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1998
    Geliefert am 03. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    252 upper richmond road mortlake t/no;-SY48493. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Mai 1996
    Geliefert am 05. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 244 upper richmond road west, east sheen, london t/no. SY42198 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Mai 1996
    Geliefert am 05. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 252 upper richmond road west east sheen london y/n SY48493 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1988
    Geliefert am 07. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    159 white hart lane l/b of richmond upon thames title no:- sgl 508097.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1985
    Geliefert am 25. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    236/236A/238/240/242 upper richmond road, west london borough of richmond-upon-thames t/n sy 229650.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 1981
    Geliefert am 11. Jan. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 1 & 1A, sheen road, richmond upon thames, london.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1982Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 1978
    Geliefert am 05. Mai 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    244 upper richmond road, east sheen, london S.W.4.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1978Registrierung einer Belastung
    • 28. Sept. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1978
    Geliefert am 20. Feb. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    56 paddington street westminster london W.1. title no 393203.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1978Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1978
    Geliefert am 20. Feb. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    502, 504 & 506 edgware road, westminster london W.2 title no. 298260 & ln 189914.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1978Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1978
    Geliefert am 20. Feb. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    45, charlton street N.W.9 camden london title no 362011.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1978Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1975
    Geliefert am 16. Jan. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and house, 111 church rd, richmond, surrey.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1975Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 1970
    Geliefert am 25. Nov. 1970
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (F/h) 45 charlton street london nw.1 (F/h) 56 paddington street london W.1 (l/h) 502, 504, 506 edgware road london . W.2 fixed and movable plant machinery and fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1970Registrierung einer Belastung
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0