DEV REALISATIONS (2019) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DEV REALISATIONS (2019) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00640611 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Meridian Business Park LE19 1WL Leicester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SIMONS DEVELOPMENTS LIMITED | 08. Juli 2004 | 08. Juli 2004 |
| SIMONS ESTATES LIMITED | 05. Juni 2000 | 05. Juni 2000 |
| SIMONS PROPERTY LIMITED | 26. März 1990 | 26. März 1990 |
| SIMONS PROPERTY GROUP LIMITED | 31. Okt. 1988 | 31. Okt. 1988 |
| SIMONS OF LINCOLN (HOLDINGS) LIMITED | 28. Okt. 1959 | 28. Okt. 1959 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2019 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 19. Okt. 2020 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 30. Nov. 2020 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 19. Okt. 2019 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Mai 2025 | 20 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Mai 2024 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Mai 2023 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | NDISC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 30 Seiten | AM22 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 32 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 42 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 43 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 36 Seiten | AM10 | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 49 Seiten | AM07 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 10 Seiten | AM02 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 46 Seiten | AM03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 991 Doddington Road Lincoln East Midlands LN6 3AA zum C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Meridian Business Park Leicester LE19 1WL am 08. Nov. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Daniel Edwin Robinson als Geschäftsführer am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip David Hodgkinson am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Richard Hodgkinson am 27. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Notification of Paul Richard Hodgkinson as a person with significant control on 15. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Harrison Kasher als Geschäftsführer am 15. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGKINSON, Paul Richard | Geschäftsführer | Ashcroft House Meridian Business Park LE19 1WL Leicester C/O Frp Advisory Llp | England | British | 35550580004 | |||||
| HODGKINSON, Philip David | Geschäftsführer | Ashcroft House Meridian Business Park LE19 1WL Leicester C/O Frp Advisory Llp | England | British | 2850580001 | |||||
| DIVER, Stephen Paul | Sekretär | 8 Riseholme Lane Riseholme LN2 2LD Lincoln Lincolnshire | British | 2850570001 | ||||||
| KASHER, Michael Harrison | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | 209631770001 | |||||||
| KENDALL, Philip James | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | 150593900001 | |||||||
| O'CONNELL, Christian John | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | 165197870001 | |||||||
| PADGHAM, Michelle Eleanor | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | 146330650001 | |||||||
| BARNES, Alan David | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | United Kingdom | British | 150599060001 | |||||
| BARNES, Anthony David | Geschäftsführer | 81 Hartsholme Drive Swanpool LN6 0HQ Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 124740130001 | |||||
| CONROY, Graham Leslie | Geschäftsführer | 2 Ridge View Harmston LN1 3QW Lincoln Lincolnshire | British | 74935030007 | ||||||
| CROSS, Paul Samuel | Geschäftsführer | Becketts Cottage 36 Deenthorpe NN17 3EP Corby Northamptonshire | British | 122403650001 | ||||||
| GUTHRIE, Fiona | Geschäftsführer | Millfield Fen Lane Dunston LN4 2HD Lincoln Lincolnshire | England | British | 107950190001 | |||||
| HAYES, Dominic Patrick Thomas | Geschäftsführer | The Old Presbytery Rudding Lane Follifoot HG3 1DQ Harrogate Yorkshire | England | British | 126532450001 | |||||
| KASHER, Michael Harrison | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | England | British | 140185150001 | |||||
| KENDALL, Philip James | Geschäftsführer | Overbury 1 Kenderdine Close Bednall ST17 0YS Stafford Staffordshire | England | British | 58364160002 | |||||
| MCINTYRE, Gordon | Geschäftsführer | 19 Robertson Close Waddington LN5 9PZ Lincoln Lincolnshire | British | 17012260001 | ||||||
| MURPHY, James William | Geschäftsführer | Pheasants Copse Rotherfield Greys RG9 4QJ Henley On Thames Oxfordshire | None | British | 4145300002 | |||||
| MURPHY, Patrick | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | England | Irish | 146322290001 | |||||
| NEWTON, Christopher Mark | Geschäftsführer | Little Orchard 23a Crag Lane HG5 8EE Knaresborough North Yorkshire | England | British | 124740290002 | |||||
| O'CONNELL, Christian John | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | England | British | 165195970001 | |||||
| ROBINSON, Thomas Daniel Edwin | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | United Kingdom | British | 189424500001 | |||||
| VYVYAN, Charles Bevil | Geschäftsführer | Riverbank Wharfeside Avenue Threshfield BD23 5BS Skipton North Yorkshire | England | British | 1972830007 | |||||
| WALTER, Giles Mark | Geschäftsführer | Walk House Blackthorn Lane Cammeringham LN1 2SH Lincoln Lincolnshire | England | British | 42034510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEV REALISATIONS (2019) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Richard Hodgkinson | 15. Aug. 2019 | Ashcroft House Meridian Business Park LE19 1WL Leicester C/O Frp Advisory Llp | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Michael Harrison Kasher | 04. Juli 2016 | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA East Midlands | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat DEV REALISATIONS (2019) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 13. Apr. 2017 Geliefert am 13. Apr. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (ad defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01).. In the debenture "land" means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant's fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 03. Juli 2009 Geliefert am 15. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in the deposit account (and which the sum of £75,000.00 has initially been placed) and all money from time to time withdrawn from it in accordance with the terms of the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination deed | Erstellt am 24. Sept. 2004 Geliefert am 06. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Under the deed the chargor agreed (inter alia) that on the insolvency of the company it would pay or deliver any payment or distribution received to the senior creditor for application towards the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Construction account charge | Erstellt am 15. Aug. 2003 Geliefert am 23. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the account and the full credit balance thereon and all rights and benefits accruing or arising in connection therewith. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Construction account charge | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 12. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the account and the full credit balance thereon and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Licence fee deposit deed | Erstellt am 28. Mai 2002 Geliefert am 06. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The amount from time to time standing to the credit of the interest earning deposit account with the governor and company of the bank of scotland of p o box 5 the mound, edinburgh EH1 1YZ | |
Kurze Angaben By way of fixed first charge the company's interest in the deposit account and the deposit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Construction cost charge | Erstellt am 28. Mai 2002 Geliefert am 06. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums in the account with the governor and company of the bank of scotland of p o box 5 the mound, edinburgh EH1 1YZ from time to time deposited therein or standing to the credit thereof (including any renewed or substituted deposits) in what ever currency denominated and all interest and other accruals accrued and accruing thereon. | |
Kurze Angaben By way of assignment all the company's right, title, benefit and interest in the account whatsoever present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Licence fee deposit deed | Erstellt am 15. Sept. 2001 Geliefert am 22. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The amount from time to time standing to the credit of the interest earning deposit account (the deposit balance) with the governor and company of the bank of scotland (the deposit account) | |
Kurze Angaben By way of fixed first charge the company's interest in the deposit account and the deposit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Construction cost charge | Erstellt am 13. Sept. 2001 Geliefert am 22. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums in the account with the governor and company of the bank of scotland from time to time deposited therein or standing to the credit thereof (including any renewed or substituted deposits) in whatever currency denominated and all interest and other accruals accrued and accruing thereon | |
Kurze Angaben By way of assignment all the company's right title benefit and interest in the account whatsoever present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1992 Geliefert am 19. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings erected thereon forming part of witham park waterside south lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Mai 1990 Geliefert am 17. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the west side of greyfriars road ipswich. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 01. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 7 newport court newport, lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1894 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 2 alowark goodramgate york. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 29. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben An area, of land on the north west of tritton road boultham moor lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 29. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the south side of sunclair drive wellingborough. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 29. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6/8 cornmarket louth lincolnshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 29. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land k/a ranskill court off shepcote lane sheffield title no syk 153883. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises situate above public library in micklegate selby (flats 1-8 micklegate, water lane, selby). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a michaelgate villas michaelgate lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a no 1 newport court newport lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a no 3 newport court newport lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H proeprty k/a 8 bollans court goodramgate york.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 9 bollans court goodramgate york. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 7 bollans court goodramgate york. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juli 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 94,96 newland lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DEV REALISATIONS (2019) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0