SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00643983 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED?
- (7011) /
- (7499) /
Wo befindet sich SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 09. Juli 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Sekretär | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| HOLLAND, Philip John | Sekretär | 9 Royle Close Chalfont St. Peter SL9 0BA Buckinghamshire | British | 74688330002 | ||||||||||
| ROBERTS, Geoffrey Michael | Sekretär | Brenchley 8 Hamilton Road DA15 7HB Sidcup Kent | British | 29217560001 | ||||||||||
| WHITE, Christine | Sekretär | 31 Denmark Street WD17 4YA Watford Hertfordshire | British | 74900200002 | ||||||||||
| BLOOMFIELD, David William | Geschäftsführer | Hillcroft The Drive Harefield Place UB10 8AQ Ickenham Middlesex | British | 7927670001 | ||||||||||
| CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11296610002 | |||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 116927100001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 163838050001 | |||||||||
| MALONE, Kenneth Daniel | Geschäftsführer | One Tree Cottage 18 Woodside Avenue HP9 1JJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60687110001 | ||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat SITE IMPROVEMENTS (DEVIZES) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Erstellt am 24. Aug. 1998 Geliefert am 25. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture | |
Kurze Angaben F/H rex cinema berkhamsted buckinghamshire being land on the south side of high street berkhamsted t/n-HD308526 together with the proceeds of sale of the same together with any property and land already charged to the security trustee by way of legal mortgage by the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. März 1993 Geliefert am 18. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from estates and general PLC to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings including the rex cinema,high st,berkhamsted,herts. T/no.hd 1067. see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1992 Geliefert am 19. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (aall as defined therein) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed | |
Kurze Angaben Please see doc M1 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0