MONITOR HOLIDAYS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMONITOR HOLIDAYS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00646236
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Feb. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    0 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 17. Feb. 2012

    • Kapital: GBP 10,000
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 16/02/2012
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beschlüsse

    Resolutions
    12 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Rank Nemo (Twenty-Six) Limited am 05. Sept. 2011

    1 SeitenCH04

    legacy

    4 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 21. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Miss Frances Bingham am 01. März 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THE RANK ORGANISATION LIMITED
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    116576210002
    BINGHAM, Frances
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish128838610001
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Sekretär
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    Sekretär
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    British71005690004
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Sekretär
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    British108784710001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Sekretär
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980002
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritish17946190001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British42996540002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Geschäftsführer
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    Geschäftsführer
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    British71005690005
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Geschäftsführer
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    British108784710001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish34191470001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Geschäftsführer
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002

    Hat MONITOR HOLIDAYS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating charge
    Erstellt am 28. Nov. 1988
    Geliefert am 09. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mecca leisure group PLC to the chargee, under the terms of the loan agreement dated 15/11/88
    Kurze Angaben
    Undertaking and al property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montague & Co Limited as Security and Trustee Agent for the Bank.
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 30. Dez. 1987
    Geliefert am 11. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from mecca leisure group PLC to samuel montagu & co limited as agent for itself and the chargees under the terms of a loan agreement dated 29/12/87
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over f/hold and l/hold property (including all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all debts and the benefit of all securities undertaking, property, rights and assets both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    • Samuel Montague & Co Limited
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • Credit Lyonnais Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Mai 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from mecca leisure group PLC to samuel montagu & co limited as agent for itself and trustee for midland bank PLC, charterhouse bank limited and the royal bank of scotland PLC under the terms of the loan agreement dated 7/11/86
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property (including all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all debts and other sums, undertakings rights and assets.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montague Co. Limited, Midland Bank PLC, Charterhouse Bank Limited
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Mai 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property (including all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all bents and otehr sums, undertakings rights and assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Mai 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property (uncluding all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all debts and other sums, undertakings rights and assets.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Trust deed
    Erstellt am 28. Juli 1986
    Geliefert am 01. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing £20,000,000 11.5% debenture stock 2011 of mecca leisure group PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed.
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future (including uncalled capital) of the company by way of first floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Equitable charge without written instrument.
    Erstellt am 17. Feb. 1986
    Geliefert am 21. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing guarantee of the principal amount and premises (if any) and interest in respect of the 11 1/2 per cent. Debenture stock 2011 of mecca leisure group PLC ("the stock)" and all other moneys intended to be secured by or payable under or pursuant to a trust deed constituting and securing the stock.
    Kurze Angaben
    Of the company by way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Dez. 1985
    Geliefert am 20. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies due or to become due from mecca leisure group limited to samuel montague & co limited as agent for itself and the other banks under the terms of a loan agreement dated 16/12/1985.
    Kurze Angaben
    . for further details see doc M81.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montague & Co. Limited as Agent for Itself and the Other Banks.
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1985Registrierung einer Belastung
    Trust deed
    Erstellt am 02. Juni 1972
    Geliefert am 09. Juni 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Further securing £750,000 debenture stock of monitor holidays LTD. Secured by a trust deed dated 30/11/64
    Kurze Angaben
    Undertaking and floating charge all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchaange Assurance
    Transaktionen
    • 09. Juni 1972Registrierung einer Belastung
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat MONITOR HOLIDAYS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Jan. 2013Aufgelöst am
    24. Feb. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0