E&G UP 1 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | E&G UP 1 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00652132 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von E&G UP 1 LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich E&G UP 1 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Wigmore Street W1U 1PB London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von E&G UP 1 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PACEMAKER INVESTMENTS LIMITED | 28. Dez. 1984 | 28. Dez. 1984 |
WELLFULL INVESTMENTS LIMITED | 10. März 1960 | 10. März 1960 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von E&G UP 1 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für E&G UP 1 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 09. Juli 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von E&G UP 1 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar | Gibraltar | British | Solicitor | 69435160001 | ||||||||
WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | Barrister At Law | 80132540006 | ||||||||
TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
HOLLAND, Philip John | Sekretär | 9 Royle Close Chalfont St. Peter SL9 0BA Buckinghamshire | British | 74688330002 | ||||||||||
ROBERTS, Geoffrey Michael | Sekretär | Brenchley 8 Hamilton Road DA15 7HB Sidcup Kent | British | 29217560001 | ||||||||||
WHITE, Christine | Sekretär | 31 Denmark Street WD17 4YA Watford Hertfordshire | British | 74900200002 | ||||||||||
BLOOMFIELD, David William | Geschäftsführer | Hillcroft The Drive Harefield Place UB10 8AQ Ickenham Middlesex | British | Company Director | 7927670001 | |||||||||
CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 11296610002 | ||||||||
CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 84076630001 | |||||||||
DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | Company Director | 116927100001 | ||||||||
HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | Chief Accountant | 163838050001 | ||||||||
LEWIS, Stephen | Geschäftsführer | Little Manor House Barrett Road KT22 9HL Fetcham Surrey | British | Company Director | 38044340001 | |||||||||
LONGMAN, Karen Sarah | Geschäftsführer | 14b Alexandra Mansions West End Lane NW6 1LU London | British | Company Director | 29163610001 | |||||||||
MALONE, Kenneth Daniel | Geschäftsführer | One Tree Cottage 18 Woodside Avenue HP9 1JJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chartered Surveyor | 60687110001 | |||||||||
REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat E&G UP 1 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fourth supplemental trust deed | Erstellt am 15. Sept. 1993 Geliefert am 24. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined) | |
Kurze Angaben See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Aug. 1993 Geliefert am 20. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part of the land comprised in t/no egl 92141 k/a unit 9 orient industrial park leyton london E10 together with certain rights over the remainder of the land comprised in title no egl 92141. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee | Erstellt am 04. Aug. 1992 Geliefert am 19. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due ro to become due from thecompany to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee of even date | |
Kurze Angaben F/H property at 3 and 3A high street chesham bucks t/no bm 1502 see 395 19 l 21/8 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of release and substitution | Erstellt am 11. Nov. 1991 Geliefert am 18. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 21.12.83, 23.8.85, 10.9.85, 14.5.86, 27.4.87, 28.4.87, 22.2.89, 26.6.91 and 12.7.91,to which it is supplemental | |
Kurze Angaben Freehold property units 6 to 9 regent's wharf, all saints street, london N1,part of t/no ngl 637226 together with all buildings and erections, fixtures and fitt,fixed plant and machinery (see form 395 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 04. März 1991 Geliefert am 11. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under tht terms of a guarantee dated 4TH march 1991, this charge and any of the other security documents to which it is a party | |
Kurze Angaben (A) l/h, the tontimes shopping court, hanley, stoke-on-trent title no sf 286975 (b) f/h land and buildings known as land lying to the north east of tower road, chorleywood title no hd 220573 and f/h land and buildings known as land at tower road, chorleywood, hertfordshire (see form 395 and continuation sheets relevant to & this charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assurance | Erstellt am 22. Feb. 1989 Geliefert am 23. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments PLC and all other moneys interded to be secured by the above and deeds dated 21/12/83 23/8/89 10/9/88, 14/05/86, 27/04/87 28/04/87 to which it is supplemented | |
Kurze Angaben F/H 53-57 (odd) high street 2 & 4 court lane skipton north yorkshire (title no nyk 34807) and f/h property at the junction of court lane & ortley street skipton (title no nyk 45395) together with all buildings erections fixtures fittings fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Feb. 1988 Geliefert am 22. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at court lane/otley street skipton north yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third supplemental trust deed | Erstellt am 28. Apr. 1987 Geliefert am 08. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,500,000 11.25 per cent first mortgage debenture stank 2018 of estates and general investments PLC & all other moneys intended to be secured as defined in the principal trust deed dated 21/12/83 & deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/H property k/a 3 & 3A high street, chesham, bucks (title no bh 1502) f/h property k/a measurex house (formerly county life house) slough road, datchet berks etc together with all bldgs, erections fixtures & fittings etc. (please see doc M148) 8 may/ln for full details of the various properties). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assurance | Erstellt am 27. Apr. 1987 Geliefert am 08. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing the outstanding £3,000,000 12.4 per cent first mortgage debenture 2008 or £10,500,000 11.25 per cent first mortgate stock 2018 of estates and general investments PLC & all other moneys intended to be secured by the deed & deeds defined therein to which it is supplemented | |
Kurze Angaben First legal mortgage of f/h property k/a the medical centre, 7 lower road, chorlywood, herts & f/h land at the rear (title no hd 220573) together with a ll blgs erections fixtures & fittings etc (see doc m/42/8 may /ln of or details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second supplemental trust deed | Erstellt am 14. Mai 1986 Geliefert am 15. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing £5,500,000 11.25% irst mortgage debenture stock 2018 of estate and gonald investments PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed, the principal deeds dated 21ST december 1983 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Further charge f/hold k/as 3 and 3A high st ishesham buckinghamshire t/n 8171502 and various at the f/hold properties together with all buildings erecties fixtures and fittings for full details see doc M97. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1986 Geliefert am 07. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold 53,55,57 high street and 2 and 4 court lane, skipton croven north yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 31. Dez. 1985 Geliefert am 06. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land fronting lower road chorley wood hertford. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental invst deed | Erstellt am 10. Sept. 1985 Geliefert am 13. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing £5,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments PLC and all other monies secured by a trust deed dated 21ST december 1983 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as 3 and 3A high street chelsham buckinghamshire bm 1502 f/hold property k/as measuex house (formerly county life house) slough road, datchet berkshire bm 41279 freehold land at the rear thereof bk 169424 freehold property k/as wallem house, slough road, datchet berkshire bk 140240 together in each case with all buildings and erections and fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 29. Jan. 1985 Geliefert am 30. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land north east of high street thame oxon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of building agreement | Erstellt am 29. Jan. 1985 Geliefert am 30. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become dur from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Building agreement and bend relating to land at high street thame oxon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Jan. 1985 Geliefert am 07. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from estates & general investments to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H land & building k/a wallen house, slough road, datchet, berkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 01. Juni 1984 Geliefert am 05. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from estates and general investments PLC the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 3 and 3A high street chestham bucks. Title no bm 1502 &/or the proceeds of sale therefo.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 17. Dez. 1981 Geliefert am 21. Dez. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Country life house, slough road, datchet, bucks title nos bm 41279 and bk 169424. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Jan. 1981 Geliefert am 26. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from estates and general investments limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Coventry life house, (now measussex house) slough road, datchet, berkshire. Title nos:- BM41279 & bk 169424 together with all buildings, fixtures, plant machinery fittings and apparatus other than trade machinery as defined by the bills of sale act 1978. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memo of deposit | Erstellt am 17. Juli 1973 Geliefert am 19. Juli 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The elms lower road, chorleywood, herts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0