E&G UP 1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameE&G UP 1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00652132
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von E&G UP 1 LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich E&G UP 1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von E&G UP 1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PACEMAKER INVESTMENTS LIMITED28. Dez. 198428. Dez. 1984
    WELLFULL INVESTMENTS LIMITED10. März 196010. März 1960

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von E&G UP 1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für E&G UP 1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Aug. 2010

    Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2010

    • Kapital: GBP 680
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 09. Juli 2010

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sect 175 comp business 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sect 175 - comp business 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sect 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Sect 175A quoted 10/11/2008
    RES13

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von E&G UP 1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister At Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Sekretär
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Sekretär
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    LEWIS, Stephen
    Little Manor House
    Barrett Road
    KT22 9HL Fetcham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Manor House
    Barrett Road
    KT22 9HL Fetcham
    Surrey
    BritishCompany Director38044340001
    LONGMAN, Karen Sarah
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    Geschäftsführer
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    BritishCompany Director29163610001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat E&G UP 1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fourth supplemental trust deed
    Erstellt am 15. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined)
    Kurze Angaben
    See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Aug. 1993
    Geliefert am 20. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part of the land comprised in t/no egl 92141 k/a unit 9 orient industrial park leyton london E10 together with certain rights over the remainder of the land comprised in title no egl 92141. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee
    Erstellt am 04. Aug. 1992
    Geliefert am 19. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due ro to become due from thecompany to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee of even date
    Kurze Angaben
    F/H property at 3 and 3A high street chesham bucks t/no bm 1502 see 395 19 l 21/8 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for Itself and Thesecured Parties as Defined
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 11. Nov. 1991
    Geliefert am 18. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 21.12.83, 23.8.85, 10.9.85, 14.5.86, 27.4.87, 28.4.87, 22.2.89, 26.6.91 and 12.7.91,to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    Freehold property units 6 to 9 regent's wharf, all saints street, london N1,part of t/no ngl 637226 together with all buildings and erections, fixtures and fitt,fixed plant and machinery (see form 395 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royl Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 04. März 1991
    Geliefert am 11. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under tht terms of a guarantee dated 4TH march 1991, this charge and any of the other security documents to which it is a party
    Kurze Angaben
    (A) l/h, the tontimes shopping court, hanley, stoke-on-trent title no sf 286975 (b) f/h land and buildings known as land lying to the north east of tower road, chorleywood title no hd 220573 and f/h land and buildings known as land at tower road, chorleywood, hertfordshire (see form 395 and continuation sheets relevant to & this charge).
    Berechtigte Personen
    • Anz Grindlands Bank Pk
    Transaktionen
    • 11. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. Juni 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assurance
    Erstellt am 22. Feb. 1989
    Geliefert am 23. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments PLC and all other moneys interded to be secured by the above and deeds dated 21/12/83 23/8/89 10/9/88, 14/05/86, 27/04/87 28/04/87 to which it is supplemented
    Kurze Angaben
    F/H 53-57 (odd) high street 2 & 4 court lane skipton north yorkshire (title no nyk 34807) and f/h property at the junction of court lane & ortley street skipton (title no nyk 45395) together with all buildings erections fixtures fittings fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 22. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1988
    Geliefert am 22. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at court lane/otley street skipton north yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Ap Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third supplemental trust deed
    Erstellt am 28. Apr. 1987
    Geliefert am 08. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £7,500,000 11.25 per cent first mortgage debenture stank 2018 of estates and general investments PLC & all other moneys intended to be secured as defined in the principal trust deed dated 21/12/83 & deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 3 & 3A high street, chesham, bucks (title no bh 1502) f/h property k/a measurex house (formerly county life house) slough road, datchet berks etc together with all bldgs, erections fixtures & fittings etc. (please see doc M148) 8 may/ln for full details of the various properties).
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    • 14. Dez. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assurance
    Erstellt am 27. Apr. 1987
    Geliefert am 08. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing the outstanding £3,000,000 12.4 per cent first mortgage debenture 2008 or £10,500,000 11.25 per cent first mortgate stock 2018 of estates and general investments PLC & all other moneys intended to be secured by the deed & deeds defined therein to which it is supplemented
    Kurze Angaben
    First legal mortgage of f/h property k/a the medical centre, 7 lower road, chorlywood, herts & f/h land at the rear (title no hd 220573) together with a ll blgs erections fixtures & fittings etc (see doc m/42/8 may /ln of or details).
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    • 10. Juni 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental trust deed
    Erstellt am 14. Mai 1986
    Geliefert am 15. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing £5,500,000 11.25% irst mortgage debenture stock 2018 of estate and gonald investments PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed, the principal deeds dated 21ST december 1983 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Further charge f/hold k/as 3 and 3A high st ishesham buckinghamshire t/n 8171502 and various at the f/hold properties together with all buildings erecties fixtures and fittings for full details see doc M97.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 14. Dez. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Mai 1986
    Geliefert am 07. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold 53,55,57 high street and 2 and 4 court lane, skipton croven north yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • A P Banks Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 22. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 1985
    Geliefert am 06. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land fronting lower road chorley wood hertford.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 10. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental invst deed
    Erstellt am 10. Sept. 1985
    Geliefert am 13. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing £5,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments PLC and all other monies secured by a trust deed dated 21ST december 1983 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as 3 and 3A high street chelsham buckinghamshire bm 1502 f/hold property k/as measuex house (formerly county life house) slough road, datchet berkshire bm 41279 freehold land at the rear thereof bk 169424 freehold property k/as wallem house, slough road, datchet berkshire bk 140240 together in each case with all buildings and erections and fixtures, fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 14. Dez. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1985
    Geliefert am 30. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land north east of high street thame oxon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    • 10. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of building agreement
    Erstellt am 29. Jan. 1985
    Geliefert am 30. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become dur from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Building agreement and bend relating to land at high street thame oxon.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    • 10. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Jan. 1985
    Geliefert am 07. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates & general investments to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H land & building k/a wallen house, slough road, datchet, berkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 01. Juni 1984
    Geliefert am 05. Juni 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 3 and 3A high street chestham bucks. Title no bm 1502 &/or the proceeds of sale therefo.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 17. Dez. 1981
    Geliefert am 21. Dez. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Country life house, slough road, datchet, bucks title nos bm 41279 and bk 169424.
    Berechtigte Personen
    • United Domminions Trust Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1981Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1981
    Geliefert am 26. Jan. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates and general investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Coventry life house, (now measussex house) slough road, datchet, berkshire. Title nos:- BM41279 & bk 169424 together with all buildings, fixtures, plant machinery fittings and apparatus other than trade machinery as defined by the bills of sale act 1978.
    Berechtigte Personen
    • Forward Frust Limited
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1981Registrierung einer Belastung
    Memo of deposit
    Erstellt am 17. Juli 1973
    Geliefert am 19. Juli 1973
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The elms lower road, chorleywood, herts.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 1973Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0