DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00670530 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit A Brook Park East NG20 8RY Shirebrook |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CARLTON PLASTICS LIMITED | 21. Sept. 1960 | 21. Sept. 1960 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 7 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Thomas James Piper als Sekretär am 01. Juli 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Cameron John Olsen als Sekretär am 01. Juli 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alastair Peter Orford Dick am 01. Mai 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Alastair Peter Orford Dick als Direktor am 14. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Rachel Isabel Lilian Stockton als Geschäftsführer am 14. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Cessation of Dunlop Slazenger International Limited as a person with significant control on 16. Dez. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 7 Seiten | AA | ||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 30. Apr. 2016 | 7 Seiten | AAMD | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Miss Rachel Isabel Lilian Stockton als Direktor am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Michael Forsey als Geschäftsführer am 14. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Adedotun Ademola Adegoke als Direktor am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael James Wallace Ashley als Geschäftsführer am 14. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 2 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER, Thomas James | Sekretär | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260022020001 | |||||||
| ADEGOKE, Adedotun Ademola | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 203129860001 | |||||
| DICK, Alastair Peter Orford | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 256598390002 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Sekretär | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MELLORS, Robert Frank | Sekretär | The Warrener Warren Row RG10 8QS Reading Berkshire | British | 30104540002 | ||||||
| MOODIE, Gordon Murray | Sekretär | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| OLSEN, Cameron John | Sekretär | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 183493780001 | |||||||
| RITCHIE, Alistair John, Sol | Sekretär | Waterman's Lodge 15 Beales Lane KT13 8JS Weybridge Surrey | British | 6417760002 | ||||||
| SIMPSON, Brian Charles | Sekretär | 15 Langham Way RG10 8AX Wargrave Berkshire | British | 47141350001 | ||||||
| TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise | Sekretär | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | British | 131967270001 | ||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | 75491680001 | |||||||
| ASHLEY, Michael James Wallace | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 95500210002 | |||||
| AUSTEN, Patrick George | Geschäftsführer | 14 Chantry View Road GU1 3XR Guildford Surrey | British | 55015730001 | ||||||
| BRANSON, David Reid | Geschäftsführer | 104 Smilax Court Greenville South Carolina Usa | American | 49245480001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Geschäftsführer | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| FORSEY, David Michael | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 147207580002 | |||||
| JACOBS, David Michael | Geschäftsführer | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | 47141160001 | ||||||
| LOVELL, Alan Charles | Geschäftsführer | The Palace House Bishops Lane SO32 1DP Bishops Waltham Hampshire | England | British | 149625410001 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Geschäftsführer | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MARNOCH, Alasdair, Mr. | Geschäftsführer | Bramble Bottom Wedmans Lane RG27 9BX Rotherwick Hampshire | England | British | 216655900001 | |||||
| MELLORS, Robert Frank | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 30104540005 | |||||
| MOODIE, Gordon Murray | Geschäftsführer | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| PARNELL, Philip John | Geschäftsführer | The Old Bell House The Common HP10 8LQ Penn Buckinghamshire | England | British | 57485400001 | |||||
| RONNIE, Christopher | Geschäftsführer | 18 Macclesfield Road SK9 2AA Wilmslow Cheshire | British | 79360390001 | ||||||
| STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 245592990001 | |||||
| THOM, James Demmink | Geschäftsführer | Tollgate Cottage Turners Hill Road RH10 4HG Crawley Down West Sussex | British | 38683120002 | ||||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Geschäftsführer | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WRAGG, James Philip | Geschäftsführer | The Old Vicarage CV35 0HD Gaydon Warwickshire | British | 77836880001 | ||||||
| WYCHERLEY, Peter | Geschäftsführer | 394 Barnsley Road Sandal WF2 6BW Wakefield West Yorkshire | British | 130910001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slazenger Carlton (Holdings) Limited | 16. Dez. 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Dunlop Slazenger International Limited | 06. Apr. 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Erstellt am 04. Apr. 1996 Geliefert am 19. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents (as defined in the charge) and all monies due or to become due from pixelframe limited (now renamed dunlop slazenger group limited) (newco) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed) under or in connection with the vendor a note (as therein defined) including the guarantee liabilities of the company to pay all monies due to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Kurze Angaben F/H land forming part of the property k/a plots 4 and 7 shire hill industrial estate saffron walden essex. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Mai 1984 Geliefert am 06. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/hold alnd l/hold property with all fixtures thereon the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. (For further details see doc M55). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0