MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00681041 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THOMAS AND SONS (CONTRACTORS) LIMITED | 19. Jan. 1961 | 19. Jan. 1961 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Bethan Anne Elizabeth Melges am 18. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Miles John Gibson als Geschäftsführer am 12. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH zum Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 24. Mai 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miles John Gibson als Direktor am 02. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Juni 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Mark Denton als Geschäftsführer am 12. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Barry Stuart Mcnicholas als Geschäftsführer am 12. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Bethan Anne Elizabeth Melges als Sekretär am 12. Juli 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Bethan Anne Elizabeth Melges als Direktor am 12. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lismirrane Industrial Park Elstree Road Elstree Hertfordshire WD6 3EA zum Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD am 20. Juli 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham Mark Denton als Direktor am 02. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Sekretär | More London Place SE1 2AF London 1 | 235842630001 | |||||||
| MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 199583330062 | |||||
| DENNINGTON, Thomas Graham | Sekretär | 7a St Catherines Road HA4 7RX Ruislip Middlesex | British | 67048860001 | ||||||
| DOYLE, Martin James | Sekretär | 18 Peter Avenue NW10 2AT London | British | 36696040001 | ||||||
| KERR, Andrew Stuart | Sekretär | Lismirrane Industrial Park Elstree Road WD6 3EA Elstree Hertfordshire | British | 97560920003 | ||||||
| MCNICHOLAS, Colin Peter | Sekretär | Woodlands Dukes Kiln Drive SL9 7HD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 1879760001 | ||||||
| POLLAND, Owen | Sekretär | 7 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | British | 90289570001 | ||||||
| SILVERMAN, Paul Martin | Sekretär | 33 Worcester Crescent Mill Hill NW7 4LP London | British | 60634020002 | ||||||
| BYRNE, Melvyn John | Geschäftsführer | Rose Cottage Little Berkhamsted Lane SG13 8LU Little Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 1778440003 | |||||
| CARTER, Steven Walter | Geschäftsführer | Westfield House Drews Park Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | British | 32220580002 | ||||||
| DENTON, Graham Mark | Geschäftsführer | Elstree Road WD6 3EA Elstree Lismirrane Industrial Park Herts United Kingdom | United Kingdom | British | 164788900001 | |||||
| GIBSON, Miles John | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 66378950003 | |||||
| KERR, Andrew Stuart | Geschäftsführer | Lismirrane Industrial Park Elstree Road WD6 3EA Elstree Hertfordshire | England | British | 97560920003 | |||||
| MAY, Martin Keith | Geschäftsführer | 3 Caribou Close Off Butts Hill Road Woodley RG5 4RA Reading Berkshire | British | 90818620001 | ||||||
| MCNICHOLAS, Barry Stuart | Geschäftsführer | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | England | British | 109676310003 | |||||
| MCNICHOLAS, Colin Peter | Geschäftsführer | Woodlands Dukes Kiln Drive SL9 7HD Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 1879760001 | |||||
| MCNICHOLAS, Kevin Michael | Geschäftsführer | The Garden Cottage HP5 1UA Latimer Buckinghamshire | British | 143130500001 | ||||||
| MCNICHOLAS, Patrick Thomas | Geschäftsführer | Lismirrane Industrial Park Elstree Road WD6 3EA Elstree Hertfordshire | British | 1879770002 | ||||||
| SMOUT, Martin John | Geschäftsführer | Greatfield Isington GU34 4PJ Near Alton Hampshire | United Kingdom | British | 117017210001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mcnicholas Construction (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Elstree Road WD6 3EA Elstree Lismirrane Industrial Park Herts United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 19. Juli 2007 Geliefert am 23. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Cross guarantee and debenture | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 30. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1999 Geliefert am 30. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The chattels described as 2 cable-jet with duct insert with kabel insert s/no 42-878 & 42-880 1 figaro on a trailer s/no 0392699 ancillary equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Jan. 1982 Geliefert am 11. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named theren to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Feb. 1976 Geliefert am 23. Feb. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. By way of fixed and floating charges see doc 27. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MCNICHOLAS COMMUNICATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0