WYNDEHAM HUBBARD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WYNDEHAM HUBBARD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00685005 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 18 Westside Centre London Road Stanway CO3 8PH Colchester England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
B.R.HUBBARD PRINTERS LIMITED | 01. März 1961 | 01. März 1961 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH England zum 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH am 20. Juli 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH England zum 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH am 02. Okt. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Zoe Repman als Sekretär am 19. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW zum 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH am 24. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul George Utting am 22. Juni 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTING, Paul George | Geschäftsführer | Westside Centre, London Road CO3 8PH Colchester 22 Essex England | England | British | Director | 65550960005 | ||||
HOLLEBONE, Paul Stephen | Sekretär | Old Orchard Dog Lane BN44 3GE Steyning West Sussex | British | Chartered Accountant | 15201600002 | |||||
HUBBARD, Barrie Weymouth | Sekretär | Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm Ridgeway S12 3XW Sheffield South Yorkshire | British | 2012700001 | ||||||
REPMAN, Zoe | Sekretär | Westside Centre London Road CO3 8PH Colchester 22 Essex England | 147370870001 | |||||||
UTTING, Paul George | Sekretär | 2 Walpole Gardens Strawberry Hill TW2 5SJ Twickenham | British | 65550960004 | ||||||
BEDSON, Bryan Stanley | Geschäftsführer | The Old Rectory Patching BN13 3XF Arundel West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 18576770001 | ||||
COPPOCK, Lawrence Patrick | Geschäftsführer | The Close Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | United Kingdom | Chartered Accountant | 152718990001 | ||||
EDWARDS, Michael Ian | Geschäftsführer | 42 Petworth Close CM77 7XS Great Notley Essex | British | Chartered Accountant | 115842570001 | |||||
FOX, Colin Charles | Geschäftsführer | 18 Mount Crescent Broadmeadows DE55 3NS Alfreton Derbyshire | British | Printer | 77114410001 | |||||
HERON, Edward Richard | Geschäftsführer | 3 The Granaries Station Road CM9 4LQ Maldon Essex | British | Printer | 4125100002 | |||||
HOLLEBONE, Paul Stephen | Geschäftsführer | Old Orchard Dog Lane BN44 3GE Steyning West Sussex | England | British | Chartered Accountant | 15201600002 | ||||
HUBBARD, Barrie Weymouth | Geschäftsführer | Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm Ridgeway S12 3XW Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Printer | 2012700001 | ||||
HUBBARD, John | Geschäftsführer | 20 Morley Close Dronfield Woodhouse S18 5YQ Sheffield | United Kingdom | British | Printer | 26988890001 | ||||
MYLES, Malcolm | Geschäftsführer | 4 Longcroft Avenue Dronfield Woodhouse S18 8PJ Dronfield Sheffield | British | Printer | 29348250003 | |||||
OWEN, Jonathan Spencer | Geschäftsführer | 42 Woodland Avenue BN3 6BL Hove East Sussex | British | Chartered Accountant | 92040070002 | |||||
PAGE, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 29 Russell Avenue MK40 3TD Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 86557080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyndeham Press Group Limited | 06. Apr. 2016 | Westside Centre, London Road CO3 8PH Colchester 22 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat WYNDEHAM HUBBARD LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Full form debenture | Erstellt am 05. Dez. 2008 Geliefert am 19. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2006 Geliefert am 08. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 01. Dez. 2006 Geliefert am 08. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns by way of security the mortgaged chattels,the benefit of any obligations,guarantees and warranties undertaken or given,all maintenance or support agreements,all authorisations,the benefit of the insurance proceeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession and restatement | Erstellt am 07. Juni 2006 Geliefert am 13. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Property being, the bentalls complex, colchester road, maldon, essex t/no EX443872. Castle press, 371, victoria street,grimsby t/no HS165423. Unit 11/12 grange industrial estate, grange road, southwick, west sussex t/no WSX142782. For details of further property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Juli 2005 Geliefert am 02. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assignment of komori lithrone L44011 four colour offset printing press serial number 1063 ("the equipment") including any part or parts thereto and all additions alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Aug. 1993 Geliefert am 16. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-callywhite lane dronfield in the county of derby and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 23. Juli 1993 Geliefert am 30. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed | Erstellt am 21. Sept. 1982 Geliefert am 30. Sept. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to williams & glyn's bank PLC supplemental to a debenture dated 15 jan. 1965. | |
Kurze Angaben All book debts & other debts present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1980 Geliefert am 07. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land and buildings fronting callywhite lane, dronfield, north east derbyshire together with all fixtures whatsoever now or at any time there after affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. all fixed and moveable plant, machinery and fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 1976 Geliefert am 22. Nov. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD. | |
Kurze Angaben 1. f/h piece or parcel of land situate fronting to callywhite lane dronfield derbyshire containing 943 sq yds approx: excepting therefrom 200 sq. Yards. 2. and further pieces of land situate nr to gallywhite lane aforesaid. Together with all fixtures whatsoever, defined by sect 5 of the bills of sale act 1878. all fixed & movable plant machinery & fixtures, implements & utensils from time to time therein or thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 15. Jan. 1965 Geliefert am 20. Jan. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD. | |
Kurze Angaben Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital with all buildings & fixtures (see doc. 20). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0