HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00687138 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?
- (2213) /
Wo befindet sich HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 288 High Street RH4 1QT Dorking Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HIGHBURY-HARPERS LIMITED | 07. Juni 2002 | 07. Juni 2002 |
| HARPER TRADE JOURNALS LIMITED | 21. März 1961 | 21. März 1961 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Dummett als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von William Twyman Iii Comfort als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRD, Fiona Mary | Sekretär | Grantley Close GU4 8DL Shalford 2 Surrey | Irish | 136809690001 | ||||||
| COMFORT, William Twyman Iii | Geschäftsführer | 21 Manresa Road Chelsea SW3 6LZ London Flat 2 | Uk | United States | 90962970002 | |||||
| ANJARWALLA, Hafeez Kaiyumali | Sekretär | 215 Wandsworth Bridge Road Fulham SW6 2TT London | British | 82450700001 | ||||||
| CARTER, Neal | Sekretär | 58 Almond Grove Hempstead ME7 3SE Gillingham Kent | British | 82064550001 | ||||||
| CHALMERS, Alan David | Sekretär | 39 Drayton Gardens W13 0LG London | British | 50887640001 | ||||||
| COSTELLO, Kieran James | Sekretär | 79 Priory Road Crouch End N8 8LR London | British | 31958660002 | ||||||
| DAVIES, Owen Wyn | Sekretär | SW20 | British | 45241980002 | ||||||
| LAW, Bruce Marcus Alexander | Sekretär | 106 Ashley Road KT12 1HP Walton On Thames Surrey | British | 31491310001 | ||||||
| NICOLL, Derek | Sekretär | 118 Fleet Road GU14 9RG Farnborough Hampshire | British | 56177890001 | ||||||
| HAL MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | Hanover House 14 Hanover Square W1S 1HP London | 2851030001 | |||||||
| ATKIN, Timothy John | Geschäftsführer | 40 Clive Road SW19 2JB London | British | 73590020001 | ||||||
| BARKER, Pamela Jeanne | Geschäftsführer | 12 Turnstone House Star Place E1W 1AE London | British | 26089600003 | ||||||
| BARKLEM, Nigel Jeremy | Geschäftsführer | Lambridge Lane RG9 4NR Henley-On-Thames Badgemore End Oxfordshire United Kingdom | England | British | 131559650001 | |||||
| BARNARD, Lisa Jane | Geschäftsführer | 78 Whitehall Park N19 3TN London | England | British | 73297090001 | |||||
| BLOXHAM, John | Geschäftsführer | 34 Mannock Drive IG10 2JB Loughton Essex | British | 8630660002 | ||||||
| CHALMERS, Alan David | Geschäftsführer | 39 Drayton Gardens W13 0LG London | British | 50887640001 | ||||||
| DAVIES, Owen Wyn | Geschäftsführer | SW20 | United Kingdom | British | 45241980002 | |||||
| DUMMETT, Robin Piers | Geschäftsführer | St Albans Gardens TW11 8AE Teddington 19 Middlesex | United Kingdom | British | 124151850003 | |||||
| FLETCHER, Ian David | Geschäftsführer | Herbert House High Laver CM5 0DZ Ongar Essex | United Kingdom | British | 41834060002 | |||||
| GILCHRIST, Andrew Iain | Geschäftsführer | The Penthouse 61 Randolph Avenue W9 1DW London | England | British | 89940590001 | |||||
| HAWSER, Anthony | Geschäftsführer | 22 Wilton Street SW1X 7AX London | British | 8207480001 | ||||||
| HEY, Charlotte Louise | Geschäftsführer | 109 Victoria Road NW6 6TD London | United Kingdom | British | 73589970001 | |||||
| ISAAC, Jeremy David Gower | Geschäftsführer | 1 Chaldon Road SW6 7NH London | British | 62088640004 | ||||||
| JUDE, Nicholas Frederick | Geschäftsführer | Apartment 124 Baltic Quay 1 Sweden Gate SE16 7TG Surrey Quays London | British | 87555310001 | ||||||
| RANKIN, Stephanie Mabel Alexandra | Geschäftsführer | 15 Oliver Avenue SE25 6TY London | British | 26467980001 | ||||||
| SALTER, Anthony Richard | Geschäftsführer | 38 Bennett Park Blackheath SE3 9RB London | United Kingdom | British | 104471190001 | |||||
| SATCHWILL, Peter Christopher | Geschäftsführer | 7 Autumn Walk Wargrave RG10 8BS Reading Berkshire | England | British | 82587650001 | |||||
| SIMPSON, Mark Andrew Goodman | Geschäftsführer | Littleton House Blandford St. Mary DT11 9NA Blandford Forum Dorset | British | 56280120002 | ||||||
| STRAKER, Patrick Vincent | Geschäftsführer | Kier Lodge Heath House Road GU22 0RD Woking Surrey | British | 8172810001 | ||||||
| STRAKER, Stephen Vincent | Geschäftsführer | Cromden Lodge Manor Road RH2 Reigate Surrey | British | 8593930001 | ||||||
| STRAKER, Timothy John | Geschäftsführer | Little Danley Lynchmere GU27 Haslemere Surrey | British | 8596110001 | ||||||
| TAYLOR, Marijke Janneke | Geschäftsführer | 54 Telford Avenue Streatham Hill SW2 4XF London | Dutch | 35951300001 | ||||||
| THACKRAY, Neil | Geschäftsführer | Herrings Twineham Lane RH17 5NP Twineham West Sussex | United Kingdom | British | 77633700002 | |||||
| TORINO, Peter Antony | Geschäftsführer | 25 Leith Mansions Grantully Road Maida Vale W9 1LQ London | England | British | 30945050002 | |||||
| WINTLE, Donald William | Gesch äftsführer | Thicket Cottage Littlewick Green SL6 Maidenhead Berks | British | 8630670001 |
Hat HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Juni 2005 Geliefert am 04. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between the company (the chargor) and barclays bank PLC (the agent) | Erstellt am 22. Sept. 2000 Geliefert am 27. Sept. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of any obligor (as defined) to each transaction party (as defined) under each transaction document (as defined) to which the chargor is a party | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge supplemental to a guarantee and debenture dated 8TH july 1996 issued by the company | Erstellt am 23. Sept. 1998 Geliefert am 05. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid guarantee and debenture | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in or aising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 27TH february 1998 for full details please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 20. Feb. 1998 Geliefert am 02. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a factoring agreement (as therein defined) or otherwise | |
Kurze Angaben Any debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason and all indebtedness owing or due to the company on any account with the related rights thereto and a floating charge all monies received in respect of the other debts as shall stand released from the fixed charge above. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1996 Geliefert am 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or harpers press limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part of the fourth floor in the north block of harling house, 47/51 great suffolk street, london borough of southwark as comprised in a lease dated 12-1-1996. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or harpers press limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 29. Apr. 1992 Geliefert am 02. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 14. Feb. 1990 Geliefert am 21. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 10. Mai 1984 Geliefert am 22. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts & other debts present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0