HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED

HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00695283
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HILTON HOTELS (U.K) LIMITED12. Juni 196112. Juni 1961

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis01. Dez. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung15. Dez. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis01. Dez. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    4 SeitenRP01CS01

    replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    4 SeitenRP01CS01

    replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    4 SeitenRP01CS01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 21. Nov. 2016

    • Kapital: GBP 40,100,204.000085
    4 SeitenSH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Robert Vincent am 29. Jan. 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    42 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Kimberly Jane Coari als Geschäftsführer am 04. Okt. 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    41 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    40 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Kimberly Jane Coari am 01. März 2021

    2 SeitenCH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 01. Juni 2023

    • Kapital: GBP 40,100,202.000085
    8 SeitenSH01

    03/06/23 Statement of Capital gbp 40100108.000001

    6 SeitenCS01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    06. Feb. 2026Replaced A second filed CS01 (Statement of Capital and Shareholder Information) was replaced on 06/02/2026

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    5 SeitenMA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Mckay Wilson am 31. Okt. 2022

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Mckay Wilson am 03. Okt. 2022

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    39 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr George Christopher Ogle am 28. Jan. 2022

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Geoffrey Beeston am 24. Juni 2021

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    42 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish188237620002
    BEESTON, Richard Geoffrey
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish242993840002
    CASSIDY, Stephen Patrick
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish243441390001
    MOMDJIAN, Michelle
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish253271050001
    OGLE, George Christopher
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish253271070002
    PERCIVAL, James Owen
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish161274380001
    VINCENT, Simon Robert
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish102638930017
    WILSON, Brian Mckay
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish125151140005
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Sekretär
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Sekretär
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    ADAMS, Philip Arthur Leonard
    118 Rickmansworth Road
    WD1 7JG Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    118 Rickmansworth Road
    WD1 7JG Watford
    Hertfordshire
    British56142800001
    ALLEN, David William Richard
    38 Rogers Mead
    PO11 0PL Hayling Island
    Hampshire
    Geschäftsführer
    38 Rogers Mead
    PO11 0PL Hayling Island
    Hampshire
    British69500070001
    ANDREW, David
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41761510002
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Geschäftsführer
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritish130102260001
    BOULD, Christopher John
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    British110275470001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    COARI, Kimberly Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish265529150002
    DOBBS, John Anthony
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    British120544260001
    FARROW, James Roger Charles
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    British9585240001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Usa106914780001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Geschäftsführer
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglish142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Geschäftsführer
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    British64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    British116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HEATH, Christopher Philip
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish205835660001
    HIRST, Michael Barry
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish40994810001
    HUGHES, Andrew Lawrence
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish109749210001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    HUMPHREYS, Stephen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    British71438830004
    JAMES, Paul Frederick
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    British48791500001
    JARVIS, David William
    The Old Vicarage
    Mark
    TA9 4NN Somerset
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Mark
    TA9 4NN Somerset
    British103569310001
    JONES, Annie Marie
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish162019090001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    England
    18. Okt. 2016
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer10270040
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    06. Apr. 2016
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    Ja
    RechtsformLimited Liability Partnership
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageLimited Liability Partnerships Act 2000
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerOc392495
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0