HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00695283 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HILTON HOTELS (U.K) LIMITED | 12. Juni 1961 | 12. Juni 1961 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Dez. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 15. Dez. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Dez. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date | 4 Seiten | RP01CS01 | ||||||||||||||
replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date | 4 Seiten | RP01CS01 | ||||||||||||||
replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date | 4 Seiten | RP01CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 21. Nov. 2016
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Robert Vincent am 29. Jan. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 42 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kimberly Jane Coari als Geschäftsführer am 04. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 41 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 40 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kimberly Jane Coari am 01. März 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 01. Juni 2023
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
03/06/23 Statement of Capital gbp 40100108.000001 | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 5 Seiten | MA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Mckay Wilson am 31. Okt. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Mckay Wilson am 03. Okt. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 39 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr George Christopher Ogle am 28. Jan. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Geoffrey Beeston am 24. Juni 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 42 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT SECRETARY LIMITED | Sekretär | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 125128960001 | |||||||
| BEASLEY, Stuart | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 188237620002 | |||||
| BEESTON, Richard Geoffrey | Geschäftsführer | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | 242993840002 | |||||
| CASSIDY, Stephen Patrick | Geschäftsführer | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | 243441390001 | |||||
| MOMDJIAN, Michelle | Geschäftsführer | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | 253271050001 | |||||
| OGLE, George Christopher | Geschäftsführer | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | 253271070002 | |||||
| PERCIVAL, James Owen | Geschäftsführer | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Herts | United Kingdom | British | 161274380001 | |||||
| VINCENT, Simon Robert | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | England | British | 102638930017 | |||||
| WILSON, Brian Mckay | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 125151140005 | |||||
| HUGHES, Barbara | Sekretär | Flat 3 11 Hazelmere Road NW6 6PY London | British | 45702460001 | ||||||
| WILSON, Brian | Sekretär | Tudor Cottage 70 High Street, Eaton Bray LU6 2DP Dunstable | British | 125151140001 | ||||||
| LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 60530770001 | |||||||
| ADAMS, Philip Arthur Leonard | Geschäftsführer | 118 Rickmansworth Road WD1 7JG Watford Hertfordshire | British | 56142800001 | ||||||
| ALLEN, David William Richard | Geschäftsführer | 38 Rogers Mead PO11 0PL Hayling Island Hampshire | British | 69500070001 | ||||||
| ANDREW, David | Geschäftsführer | Briarclough Cross Oak Road HP4 3NA Berkhamsted Hertfordshire | British | 41761510002 | ||||||
| BAMSEY, John Anthony | Geschäftsführer | Cranley Road Burwood Park KT12 5BL Hersham Treetops 26 Surrey | England | British | 130102260001 | |||||
| BOULD, Christopher John | Geschäftsführer | The West Wing Pensax Court Pensax WR6 6XJ Worcester Worcestershire | British | 110275470001 | ||||||
| BRADLEY, Adrian Paul | Geschäftsführer | The Spinney Misbourne Avenue SL9 0PF Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| COARI, Kimberly Jane | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 265529150002 | |||||
| DOBBS, John Anthony | Geschäftsführer | 11a North Park Avenue LS8 1DN Leeds West Yorkshire | British | 120544260001 | ||||||
| FARROW, James Roger Charles | Geschäftsführer | 7 Downham Place South Shore FY4 1PW Blackpool Lancashire | British | 9585240001 | ||||||
| FRIEDMAN, Howard | Geschäftsführer | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | Usa | 106914780001 | ||||||
| GOSLING, Peter Charles | Geschäftsführer | 95 Worcester Road SM2 6QL Cheam Surrey | England | English | 142633640001 | |||||
| HARRIS, Anthony Richard | Geschäftsführer | 43 Alma Square NW8 9PY London | British | 64357620006 | ||||||
| HARVEY, Paul Victor | Geschäftsführer | Flat 2, The Cotton Mill 35 King Street LE1 6RN Leicester Leicestershire | British | 116809270001 | ||||||
| HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Bishops Platt Norlands Lane TW20 8SS Thorpe Surrey | United Kingdom | British | 88628480001 | |||||
| HEATH, Christopher Philip | Geschäftsführer | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire England | England | British | 205835660001 | |||||
| HIRST, Michael Barry | Geschäftsführer | 16 Prowse Avenue Bushey WD2 1JR Watford Hertfordshire | England | British | 40994810001 | |||||
| HUGHES, Andrew Lawrence | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | England | British | 109749210001 | |||||
| HUGHES-RIXHAM, Ian | Geschäftsführer | 1 Grange Road HP23 5JP Tring Hertfordshire | British | 143730250001 | ||||||
| HUGHES-RIXHAM, Ian | Geschäftsführer | 1 Grange Road HP23 5JP Tring Hertfordshire | British | 143730250001 | ||||||
| HUMPHREYS, Stephen | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | British | 71438830004 | ||||||
| JAMES, Paul Frederick | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | British | 48791500001 | ||||||
| JARVIS, David William | Geschäftsführer | The Old Vicarage Mark TA9 4NN Somerset | British | 103569310001 | ||||||
| JONES, Annie Marie | Geschäftsführer | 2 Lodge Close SL7 1RB Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 162019090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton International Ip Holding Limited | 18. Okt. 2016 | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Hilton Worldwide Holding Llp | 06. Apr. 2016 | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0