J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00704098 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Anns Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Sept. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maurice Delon Jones am 14. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 14. März 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Adrian David Gray als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURGESS, Richard Trevor | Sekretär | 6 Pleshey Close SS1 3SP Thorpe Bay Essex | British | 36253260001 | ||||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Sekretär | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Sekretär | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Sekretär | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| BURGESS, Richard Trevor | Geschäftsführer | 6 Pleshey Close SS1 3SP Thorpe Bay Essex | British | 36253260001 | ||||||||||
| CUTHBERTSON, George Brian | Geschäftsführer | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 6996370001 | |||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| GORDON, Alastair Neil | Geschäftsführer | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | 61620710001 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| O'CONNOR, Patrick Finbarr | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 66 Cumberland Mills Square Saunders Ness Road E14 3BJ Isle Of Dogs London | British/Irish | 900010100001 | ||||||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Geschäftsführer | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||||||
| WILTSHIRE, Harold Phillip | Geschäftsführer | Dipley Mill Dipley RG27 8JP Hartley Wintney Hampshire | British | 930220001 | ||||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
Hat J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 11. Feb. 1992 Geliefert am 25. Feb. 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due under the terms of an underlease dated 11 feb 1992 | |
Kurze Angaben The deposit of £500,000 held in aseperate designated account at barclays bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment relating to debentures dated 26/09/90 & 18/12/90 | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 16. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent and/or each obligor (as defined) under the terms of the guarantee (as defined) and this deed of amendment | |
Kurze Angaben (See form 395 and cont'd sheets relevant to this deed of amendment). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee (as agent and trustee for itself and for each bank) (as defined) under the terms of the indebtedness agreement the coffee refinancing agreement and this charge. | |
Kurze Angaben (Please see 395 M22 and continuation sheets for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee (as agent and trustee for itself and for each bank) (as ined) under the terms of the indebtedness agreements and this charge | |
Kurze Angaben (Please see 395 M21 and continuation sheets for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 10. Juli 1990 Geliefert am 14. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Us $3 million dollars due from the company and/or the rayner coffee international partnership to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Assignment of rights arising under a) an agreament dated 17/8/88 b) an agrement supplemental thereof dated 6/9/89 c) a deed of pledge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement | Erstellt am 06. Juni 1990 Geliefert am 27. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben A continuing interest in the following property 1) all gold deliverd by cibc to the company on consignment from time to time; and 2) all gold purchased by the company from cibc under the agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0