INBIS TECHNOLOGY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INBIS TECHNOLOGY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00710001 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 The Brooms Emersons Green BS16 7FD Bristol Avon |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
RICARDO AEROSPACE LIMITED | 20. Jan. 1992 | 20. Jan. 1992 |
SAC TECHNOLOGY LIMITED | 20. Sept. 1985 | 20. Sept. 1985 |
S.A.C. TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 15. Dez. 1982 | 15. Dez. 1982 |
S.A.C.BRISTOL LIMITED | 07. Dez. 1961 | 07. Dez. 1961 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Richard Bradley am 16. Aug. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Pearce als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Eur Ing Christopher Michael Pearce am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael John Sheehan am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUNCE, David Christopher | Sekretär | Sunnyside Cottage Lane Croston PR26 9JJ Preston | British | 58394380003 | ||||||
BRADLEY, David Richard | Geschäftsführer | Hall Lane Wrightington WN6 9EN Wigan Four Acres Lancashire England | United Kingdom | British | Dept Managing Director | 24337370003 | ||||
CAUNCE, David Christopher | Geschäftsführer | Sunnyside Cottage Lane Croston PR26 9JJ Preston | United Kingdom | British | Finance Director | 58394380003 | ||||
SHEEHAN, Michael John | Geschäftsführer | Sunnybank 4a Province Lane Long Ashton BS41 9DG Bristol Avon | England | British | Director | 108094890001 | ||||
EDE, Helen Lesley | Sekretär | 84 Aubrey Road Bedminster BS3 3EU Bristol Avon | British | 31688980002 | ||||||
GOODBURN, Andrew Robert | Sekretär | Deacons Hay Beaconsfield Road Chelwood Gate RH17 7LG Redhill Sussex | British | Finance Director | 38653170001 | |||||
PATEL, Bipin | Sekretär | 58 Colebridge Avenue GL2 0RH Longlevens Gloucestershire | British | 97984440001 | ||||||
WILKINSON, Terry | Sekretär | 4 Red House Lane BS9 3RY Westbury On Trym Avon | British | 33959840001 | ||||||
BAKER, John Barrie | Geschäftsführer | Walsall Road B74 4QA Sutton Coldfield 219 West Midlands | United Kingdom | British | Managing Director | 42982690001 | ||||
BELL, John Maclean | Geschäftsführer | Tower House Charlton Road, Holcombe BA3 5EW Bath Avonmouth | British | Commercial Director | 34179480001 | |||||
BODNAR, Adam Antal | Geschäftsführer | Tanners House Tanners Hill SN16 0NB Sherston Wiltshire | British | Managing Director | 88233670001 | |||||
DAVIES, Richard Thomas | Geschäftsführer | 11 Sydney Place BA2 6NF Bath Avon | British | Director | 37079410001 | |||||
EVANS, Douglas Herbert | Geschäftsführer | Portelet 25 Foley Avenue Tettenhall Wood WV6 8LX Wolverhampton Staffordshire | England | British | Director | 36973820001 | ||||
GOODBURN, Andrew Robert | Geschäftsführer | Deacons Hay Beaconsfield Road Chelwood Gate RH17 7LG Redhill Sussex | England | British | Finance Director | 38653170001 | ||||
HEAMAN, Jennifer Anne | Geschäftsführer | Beta Beta Post Office Lane, Flax Bourton BS48 3PZ Bristol | United Kingdom | British | Managing Director | 1034220003 | ||||
IVES, Anthony Reginald | Geschäftsführer | Drovers Cottage Valley Road DT11 9JE Tarrant Keyneystone Dorset | British | Engineer | 33959810001 | |||||
LAWTON, Robert William | Geschäftsführer | West Hayes Sandlea Close SN14 7JR Yatton Keynell | United Kingdom | British | Director | 86369990001 | ||||
LEIGH, Ian | Geschäftsführer | 6 Penrice Fold Ellenbrook M28 1ZB Worsley | England | British | Accountant | 58629350001 | ||||
OAKES, Andrew Thomas | Geschäftsführer | 83 Lakewood Road Chandlers Ford SO53 5AD Eastleigh Hampshire | British | Company Director | 67816220001 | |||||
PEARCE, Christopher Michael, Eur Ing | Geschäftsführer | 4 High Meadow The Wheatridge GL4 4DG Gloucester Gloucestershire | England | British | Technical Director | 37897850002 | ||||
TORKINGTON, Peter | Geschäftsführer | 10 Stokefield Close Thornbury BS12 1HE Bristol Avon | British | Engineer | 18016580001 | |||||
WELLS, Philip Henry | Geschäftsführer | 188 Stoke Lane Westbury On Trym BS9 3RU Bristol Avon | British | Engineer | 2401320001 | |||||
WILKINSON, Terry | Geschäftsführer | 4 Red House Lane BS9 3RY Westbury On Trym Avon | British | Accountant | 33959840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INBIS TECHNOLOGY LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assystem Uk Ltd | 30. Juni 2016 | Club Street Bamber Bridge PR5 6FN Preston Club Street England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INBIS TECHNOLOGY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture deed | Erstellt am 21. Aug. 2000 Geliefert am 22. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 18. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
General assignment agreement | Erstellt am 29. Mai 1997 Geliefert am 03. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as ricardo aerospace limited) to the chargee under or in connection with the loan (as defined) | |
Kurze Angaben All their present and future receivables (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Share pledge agreement | Erstellt am 14. März 1997 Geliefert am 25. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The company's obligations to the chargee under the terms of a facility agreement and a guarantee and debenture both dated 6TH february 1997 | |
Kurze Angaben In particular including bearer shares of 1,000 swiss francs which the pledgor owns in ricardo consultants ag all claims documents and title holdings coins bank notes and other objects of value. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture, made between inbis group limited (as principal borrower) (1), the other companies listed in part ii of the attached schedule (as borrowers) (2) and banque indosuez (the "bank") (3), issued by the company | Erstellt am 06. Feb. 1997 Geliefert am 12. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or by any other group company (including any other company) to the chargee in any currency, and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction, under the terms and contiditions contained in this guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Registered property - f/h- club street works club street bamber bridge preston PR5 5FN, t/n-LA578544, proprietor - ricardo properties limited. L/h-part of the lower ground floor st john's house st john's square wolverhampton WV2 4LS t/n-SF38751, proprietor - ricardo aerospace limited. Unregistered property - part of ground floor norman house heritage gate derby, proprietor - ricardo aerospace limited.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement | Erstellt am 30. März 1992 Geliefert am 09. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to becoem due from the company to lloyds bank PLC under the terms of the deposit agreement. | |
Kurze Angaben All the rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. Please see doc for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set-off | Erstellt am 04. Juli 1986 Geliefert am 11. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Aug. 1985 Geliefert am 13. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold brunswick house upper york street bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set-off | Erstellt am 05. März 1984 Geliefert am 07. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or s a c consultants limited to the chargee | |
Kurze Angaben Any sums standing to the credit of any present or future accounts of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set-off | Erstellt am 24. Dez. 1982 Geliefert am 30. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0