SEA VENTURES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSEA VENTURES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00711212
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SEA VENTURES LIMITED?

    • (6110) /

    Wo befindet sich SEA VENTURES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1640 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AH Fareham
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SEA VENTURES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für SEA VENTURES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Nov. 2012

    6 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Juni 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Juni 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Juni 2010

    7 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Juni 2009

    12 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    12 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Apr. 2009

    14 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    10 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    18 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von SEA VENTURES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WHITE, David Vernon, Financial Director
    Woodvale 10 Horns Drove
    Rownhams
    SO16 8AH Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    Woodvale 10 Horns Drove
    Rownhams
    SO16 8AH Southampton
    Hampshire
    British8576190001
    DE QUERVAIN COLLEY, Alfred Nigel
    5 Springfield Close
    SO41 3SR Lymington
    Hampshire
    Geschäftsführer
    5 Springfield Close
    SO41 3SR Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish25281580003
    DUFFIN, David Stuart
    19 Oaklands
    SO41 3TH Lymington
    Hampshire
    Geschäftsführer
    19 Oaklands
    SO41 3TH Lymington
    Hampshire
    British125294520001
    WHITE, David Vernon, Financial Director
    Woodvale 10 Horns Drove
    Rownhams
    SO16 8AH Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Woodvale 10 Horns Drove
    Rownhams
    SO16 8AH Southampton
    Hampshire
    British8576190001
    DE QUERVAIN COLLEY, Alfred John
    5 Springfield Close
    SO41 3SR Lymington
    Hampshire
    Sekretär
    5 Springfield Close
    SO41 3SR Lymington
    Hampshire
    British59296850001
    WILSON, Gordon Mcivor
    11 Croft End
    Letcombe Regis
    OX12 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Sekretär
    11 Croft End
    Letcombe Regis
    OX12 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British102346810001
    DE QUERVAIN COLLEY, Alfred John
    5 Springfield Close
    SO41 3SR Lymington
    Hampshire
    Geschäftsführer
    5 Springfield Close
    SO41 3SR Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish59296850001
    INNES-KER, Peter
    High Beech Cottage
    Kingsley Green
    GU27 3LL Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    High Beech Cottage
    Kingsley Green
    GU27 3LL Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish57427610001
    LE CONTE, Jonathan Nicholas
    The Barn Sarnian Lodge
    Pont Valliant Lane
    GY1 2UQ St Peter Port
    Guernsey
    Geschäftsführer
    The Barn Sarnian Lodge
    Pont Valliant Lane
    GY1 2UQ St Peter Port
    Guernsey
    British71947770002
    WILSON, Gordon Mcivor
    11 Croft End
    Letcombe Regis
    OX12 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    11 Croft End
    Letcombe Regis
    OX12 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish102346810001
    WORTH, Albert Walter Kench
    3 Seaway
    Barton On Sea
    BH25 5PL New Milton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    3 Seaway
    Barton On Sea
    BH25 5PL New Milton
    Hampshire
    British3630150001

    Hat SEA VENTURES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of mortgage
    Erstellt am 04. Aug. 2008
    Geliefert am 06. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sun odyssey 2500(hin fr-IRI02375A808) and in her boats and appurtenances. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2008
    Geliefert am 06. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel beneteau oceans 343 "jalou" (on: 910883) and in her boats appurtenances. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 30. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel name veanneau prestige 30 FRIRIF2065C707.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 30. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel name bavaria 42 de-BAVG42B9K899.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 03. Juli 2008
    Geliefert am 04. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel southerly 105 "navassa" (yard no 29) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Juni 2008
    Geliefert am 20. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's interest in the account and the deposit balance from time to time and all money from time to time withdrawn from the account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hythe Marina Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 06. Juni 2008
    Geliefert am 07. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel westerly falcon, andromeda (yard number AF13) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 06. Juni 2008
    Geliefert am 07. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sun fast 3200I (hin:fr-IRI32003J708) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 17. Apr. 2008
    Geliefert am 22. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in the account and the deposit balance see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hythe Marina Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 07. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel name aquador 32C fi-AQUM0252B808 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 07. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel name aquador 28 ht fi-AQU00040C808 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 07. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel name aquador 26HT fi-AQUR0026B808 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 17. März 2008
    Geliefert am 19. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64 shares in the vessel name (aquador 23 4T) and in her boats and appurtenances. Fi-AQUG0553J708.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2008
    Mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 28. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    64 shares in the vessel aquador 26 ht (hin: fi-AQUH0396D606) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 11. Dez. 2007
    Geliefert am 12. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sunkiss "seacroft" (on: 733234) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 08. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel aquador (fi-AQUL0019G405) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 20. Juli 2007
    Geliefert am 24. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel bavaria 44 'kosi' (hin@de-BAVS4G8D202) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 10. Juli 2007
    Geliefert am 14. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel fairline corniche "sancerre" hin 261 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 10. Juli 2007
    Geliefert am 14. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sun fast "entropy" hin fr-IRI00892E303 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 14. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sun odyssey 36.2 "flying colours of southampton" official number 904797 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 14. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel x-332 "peanut" hin dx-XYA33300E101 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 25. Juni 2007
    Geliefert am 14. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel aquador 23 ht "maid of honour" hin FIAQUG0005J102 and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 04. Juni 2007
    Geliefert am 09. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel hunter pilot 27 (hin: GB-HUNPA033J696) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 04. Juni 2007
    Geliefert am 09. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sun charm 39 (hin: 37645) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 09. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel jeanneau sun odyssey 32 (hin: fr-IRI00186F202) and in her boats and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SEA VENTURES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Okt. 2008Beginn der Verwaltung
    09. Juni 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Carl Derek Faulds
    Portland Business & Financial
    1640 Parkway
    PO15 7AH Solent Business Park
    Whitely, Fareham Hants
    Praktiker
    Portland Business & Financial
    1640 Parkway
    PO15 7AH Solent Business Park
    Whitely, Fareham Hants
    James Richard Tickell
    1640 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AH Fareham
    Praktiker
    1640 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AH Fareham
    2
    DatumTyp
    09. Juni 2009Beginn der Liquidation
    03. März 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Carl Derek Faulds
    Portland Business & Financial
    1640 Parkway
    PO15 7AH Solent Business Park
    Whitely, Fareham Hants
    Praktiker
    Portland Business & Financial
    1640 Parkway
    PO15 7AH Solent Business Park
    Whitely, Fareham Hants
    James Richard Tickell
    Portland
    1640 Parkway
    PO15 7AH Solent Business Part, Whiteley
    Fareham Hampshire
    Praktiker
    Portland
    1640 Parkway
    PO15 7AH Solent Business Part, Whiteley
    Fareham Hampshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0