SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00712726
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    • (3663) /

    Wo befindet sich SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SLOANE MANUFACTURING LIMITED14. Dez. 199014. Dez. 1990
    SLOANE MANUFACTURING (DECORATIONS) LIMITED11. Jan. 196211. Jan. 1962

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Booth Drive Park Farm Estate Wellingborough Northants NN8 6GR am 08. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Sept. 2010

    LRESSP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    19 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    Seiten363(287)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    19 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    23 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SOUTHARN, James Andrew Gordon
    Coventry Road
    CV32 9JR Thurlaston
    Holly Tree Cottage
    Rugby
    Sekretär
    Coventry Road
    CV32 9JR Thurlaston
    Holly Tree Cottage
    Rugby
    BritishAccountant90654640004
    BERGGREN, Anders Jan
    White Eagle Drive
    IL 60564 Napalms
    3541
    Illinois
    United States
    Geschäftsführer
    White Eagle Drive
    IL 60564 Napalms
    3541
    Illinois
    United States
    SwedishDirector140666020001
    MAJAMAA, Antti Juhani
    Bremig 6
    D51674 Wiehl
    Germany
    Geschäftsführer
    Bremig 6
    D51674 Wiehl
    Germany
    FinnishManaging Director131309220001
    SOUTHARN, James Andrew Gordon
    Coventry Road
    CV32 9JR Thurlaston
    Holly Tree Cottage
    Rugby
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV32 9JR Thurlaston
    Holly Tree Cottage
    Rugby
    EnglandBritishAccountant90654640004
    BRINDLE, Ralph Francis
    5 Newquay Drive
    SK10 3NQ Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    5 Newquay Drive
    SK10 3NQ Macclesfield
    Cheshire
    British12628620001
    BULL, Andrew George
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    BritishDirector12520790002
    BULL, Andrew George
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    BritishCompany Director12520790002
    MCMILLAN, Ian Stuart
    4 Southfields Place
    Blakesley
    NN12 8EA Towcester
    Northamptonshire
    Sekretär
    4 Southfields Place
    Blakesley
    NN12 8EA Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Director29535520001
    SIMSON, Michael David
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    Sekretär
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    Irish5233630002
    ANDREW, Vincent Leo
    The Maltings
    Brewery Yard
    NN14 3BT Subborough
    Northants
    Geschäftsführer
    The Maltings
    Brewery Yard
    NN14 3BT Subborough
    Northants
    BritishCompany Director116947660001
    BENNETT, Stephen Scott
    Ringwood
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Ringwood
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director8689150002
    BULL, Andrew George
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector12520790002
    BULL, Andrew George
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Church View
    Orton
    NN14 1LJ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director12520790002
    COLE, John
    The Manor House 105 Norton Road
    SG6 1AG Letchworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Manor House 105 Norton Road
    SG6 1AG Letchworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director1446500001
    COPPING, John Vincent Joseph
    2 Cleburne Close
    NN9 6TN Stanwick
    Northants
    Geschäftsführer
    2 Cleburne Close
    NN9 6TN Stanwick
    Northants
    United KingdomBritishDirector107569940001
    COPPING, John Vincent Joseph
    2 Cleburne Close
    NN9 6TN Stanwick
    Northants
    Geschäftsführer
    2 Cleburne Close
    NN9 6TN Stanwick
    Northants
    United KingdomBritishDirector107569940001
    DAWES, Peter John
    Holly Cottage
    41 Main Street
    LE16 8NG Great Oxendon
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Holly Cottage
    41 Main Street
    LE16 8NG Great Oxendon
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector114422660001
    FRENCH, Roy Timothy
    5 Aldwycks Close
    Shenley Church End
    MK5 6HZ Milton Keynes
    Geschäftsführer
    5 Aldwycks Close
    Shenley Church End
    MK5 6HZ Milton Keynes
    EnglandBritishDirector90654800002
    GLUTH, Robert Charles
    1212 North Lake Shore Drive
    Chicago
    60610 Illinois
    Usa
    Geschäftsführer
    1212 North Lake Shore Drive
    Chicago
    60610 Illinois
    Usa
    AmericanCompany Executive55243550001
    HARDING, Dale Roger Lloyd
    16 Wakeling Close
    NG25 0JF Southwell
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    16 Wakeling Close
    NG25 0JF Southwell
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director9535540001
    HARPER, Arthur Richard
    90 Main Road
    Grendon
    NN7 1JW Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    90 Main Road
    Grendon
    NN7 1JW Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director7369110001
    HOBSON, Andrew Cansfield
    13 Christchurch Road
    NR2 2AE Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    13 Christchurch Road
    NR2 2AE Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director64737800001
    JONES, William Kenneth
    Waterloo House
    Harborough Road
    LE16 8NB Great Oxendon
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Waterloo House
    Harborough Road
    LE16 8NB Great Oxendon
    Northamptonshire
    BritishCompany Director82483190001
    KAY, David Moburn
    31 St Andrews Wharf
    Shad Thames
    SE1 2YN London
    Geschäftsführer
    31 St Andrews Wharf
    Shad Thames
    SE1 2YN London
    EnglandBritishCompany Director34681160001
    LEVER, Paul Ronald Scott
    Great Peter Street
    SW1P 3LR London
    35
    Geschäftsführer
    Great Peter Street
    SW1P 3LR London
    35
    United KingdomBritishCompany Director106971650001
    MCMILLAN, Ian Stuart
    4 Southfields Place
    Blakesley
    NN12 8EA Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Southfields Place
    Blakesley
    NN12 8EA Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Director29535520001
    MORRIS, Colin
    7 Templar Drive
    DA11 7NS Gravesend
    Kent
    Geschäftsführer
    7 Templar Drive
    DA11 7NS Gravesend
    Kent
    BritishCompany Director49469260001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Executive23060180001
    RAILTON, David Vaughan Hedley
    Leeward House Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Leeward House Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    BritishDirector35576080001
    ROBERTS, David Allen
    3115 Aviara Court
    Naperville
    Illinois
    60564
    Usa
    Geschäftsführer
    3115 Aviara Court
    Naperville
    Illinois
    60564
    Usa
    AmericanCompany Executive74524060002
    SIMSON, Michael David
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    Geschäftsführer
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    EnglandIrishCompany Director5233630002
    SOLOMON, Harry, Sir
    7 Inverforth House
    North End Way
    NW3 7EU London
    Geschäftsführer
    7 Inverforth House
    North End Way
    NW3 7EU London
    United KingdomBritishDirector59789810004
    STOREY, David Michael
    Northfield Cottage Hodge Lane
    Hartford
    CW8 2SE Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Northfield Cottage Hodge Lane
    Hartford
    CW8 2SE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector35599670001
    WALKER, Mark Howard
    Woodford Lodge
    123 Woodford Road
    SK7 1QB Bramhall
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Woodford Lodge
    123 Woodford Road
    SK7 1QB Bramhall
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector79317990001
    WALSH, Robert Philip
    Bridle Cottage Lower Green
    Towersey
    OX9 3QP Thame
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Bridle Cottage Lower Green
    Towersey
    OX9 3QP Thame
    Oxfordshire
    BritishCompany Director7369120002

    Hat SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Juni 1995
    Geliefert am 07. Juli 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land & buildings on the north side of hampstead avenue mildenhall industrial estate mildenhall suffolk t/no SK132130 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Aug. 1993
    Geliefert am 16. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Aug. 1988
    Geliefert am 05. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or sloane group (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 1986
    Geliefert am 27. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit D3 clock close earls barton, northampton, northamptonshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 28. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 1986
    Geliefert am 05. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed.
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings erected thereon k/a unit D3 clock close industrial estate, earls barton, northamptonshire.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 28. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sub-mortgage
    Erstellt am 16. Apr. 1986
    Geliefert am 07. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit D6 baron avenue, earls barton, northants.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 28. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Apr. 1981
    Geliefert am 22. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or display enterprises LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    • 01. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge.
    Erstellt am 17. Mai 1972
    Geliefert am 01. Juni 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from display enterprises LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any accounts of the company whether current accounts on deposit accounts.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1972Registrierung einer Belastung
    • 28. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Sept. 2010Beginn der Liquidation
    19. Apr. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gary Norton Lee
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0