SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00712726 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?
- (3663) /
Wo befindet sich SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 340 Deansgate M3 4LY Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SLOANE MANUFACTURING LIMITED | 14. Dez. 1990 | 14. Dez. 1990 |
SLOANE MANUFACTURING (DECORATIONS) LIMITED | 11. Jan. 1962 | 11. Jan. 1962 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Booth Drive Park Farm Estate Wellingborough Northants NN8 6GR am 08. Okt. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(287) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHARN, James Andrew Gordon | Sekretär | Coventry Road CV32 9JR Thurlaston Holly Tree Cottage Rugby | British | Accountant | 90654640004 | |||||
BERGGREN, Anders Jan | Geschäftsführer | White Eagle Drive IL 60564 Napalms 3541 Illinois United States | Swedish | Director | 140666020001 | |||||
MAJAMAA, Antti Juhani | Geschäftsführer | Bremig 6 D51674 Wiehl Germany | Finnish | Managing Director | 131309220001 | |||||
SOUTHARN, James Andrew Gordon | Geschäftsführer | Coventry Road CV32 9JR Thurlaston Holly Tree Cottage Rugby | England | British | Accountant | 90654640004 | ||||
BRINDLE, Ralph Francis | Sekretär | 5 Newquay Drive SK10 3NQ Macclesfield Cheshire | British | 12628620001 | ||||||
BULL, Andrew George | Sekretär | Church View Orton NN14 1LJ Kettering Northamptonshire | British | Director | 12520790002 | |||||
BULL, Andrew George | Sekretär | Church View Orton NN14 1LJ Kettering Northamptonshire | British | Company Director | 12520790002 | |||||
MCMILLAN, Ian Stuart | Sekretär | 4 Southfields Place Blakesley NN12 8EA Towcester Northamptonshire | British | Company Director | 29535520001 | |||||
SIMSON, Michael David | Sekretär | 60 Stile Hall Gardens Chiswick W4 3BU London | Irish | 5233630002 | ||||||
ANDREW, Vincent Leo | Geschäftsführer | The Maltings Brewery Yard NN14 3BT Subborough Northants | British | Company Director | 116947660001 | |||||
BENNETT, Stephen Scott | Geschäftsführer | Ringwood Coombe End KT2 7DQ Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 8689150002 | ||||
BULL, Andrew George | Geschäftsführer | Church View Orton NN14 1LJ Kettering Northamptonshire | England | British | Director | 12520790002 | ||||
BULL, Andrew George | Geschäftsführer | Church View Orton NN14 1LJ Kettering Northamptonshire | England | British | Company Director | 12520790002 | ||||
COLE, John | Geschäftsführer | The Manor House 105 Norton Road SG6 1AG Letchworth Hertfordshire | British | Company Director | 1446500001 | |||||
COPPING, John Vincent Joseph | Geschäftsführer | 2 Cleburne Close NN9 6TN Stanwick Northants | United Kingdom | British | Director | 107569940001 | ||||
COPPING, John Vincent Joseph | Geschäftsführer | 2 Cleburne Close NN9 6TN Stanwick Northants | United Kingdom | British | Director | 107569940001 | ||||
DAWES, Peter John | Geschäftsführer | Holly Cottage 41 Main Street LE16 8NG Great Oxendon Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 114422660001 | ||||
FRENCH, Roy Timothy | Geschäftsführer | 5 Aldwycks Close Shenley Church End MK5 6HZ Milton Keynes | England | British | Director | 90654800002 | ||||
GLUTH, Robert Charles | Geschäftsführer | 1212 North Lake Shore Drive Chicago 60610 Illinois Usa | American | Company Executive | 55243550001 | |||||
HARDING, Dale Roger Lloyd | Geschäftsführer | 16 Wakeling Close NG25 0JF Southwell Nottinghamshire | British | Company Director | 9535540001 | |||||
HARPER, Arthur Richard | Geschäftsführer | 90 Main Road Grendon NN7 1JW Northampton Northamptonshire | British | Company Director | 7369110001 | |||||
HOBSON, Andrew Cansfield | Geschäftsführer | 13 Christchurch Road NR2 2AE Norwich Norfolk | England | British | Company Director | 64737800001 | ||||
JONES, William Kenneth | Geschäftsführer | Waterloo House Harborough Road LE16 8NB Great Oxendon Northamptonshire | British | Company Director | 82483190001 | |||||
KAY, David Moburn | Geschäftsführer | 31 St Andrews Wharf Shad Thames SE1 2YN London | England | British | Company Director | 34681160001 | ||||
LEVER, Paul Ronald Scott | Geschäftsführer | Great Peter Street SW1P 3LR London 35 | United Kingdom | British | Company Director | 106971650001 | ||||
MCMILLAN, Ian Stuart | Geschäftsführer | 4 Southfields Place Blakesley NN12 8EA Towcester Northamptonshire | British | Company Director | 29535520001 | |||||
MORRIS, Colin | Geschäftsführer | 7 Templar Drive DA11 7NS Gravesend Kent | British | Company Director | 49469260001 | |||||
PRENTICE, Hamish Murray | Geschäftsführer | 12 Rose Gate Aglionby CA4 8AJ Carlisle Cumbria | British | Company Executive | 23060180001 | |||||
RAILTON, David Vaughan Hedley | Geschäftsführer | Leeward House Macclesfield Road SK9 7BW Alderley Edge Cheshire | British | Director | 35576080001 | |||||
ROBERTS, David Allen | Geschäftsführer | 3115 Aviara Court Naperville Illinois 60564 Usa | American | Company Executive | 74524060002 | |||||
SIMSON, Michael David | Geschäftsführer | 60 Stile Hall Gardens Chiswick W4 3BU London | England | Irish | Company Director | 5233630002 | ||||
SOLOMON, Harry, Sir | Geschäftsführer | 7 Inverforth House North End Way NW3 7EU London | United Kingdom | British | Director | 59789810004 | ||||
STOREY, David Michael | Geschäftsführer | Northfield Cottage Hodge Lane Hartford CW8 2SE Northwich Cheshire | England | British | Director | 35599670001 | ||||
WALKER, Mark Howard | Geschäftsführer | Woodford Lodge 123 Woodford Road SK7 1QB Bramhall Cheshire | United Kingdom | British | Director | 79317990001 | ||||
WALSH, Robert Philip | Geschäftsführer | Bridle Cottage Lower Green Towersey OX9 3QP Thame Oxfordshire | British | Company Director | 7369120002 |
Hat SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 29. Juni 1995 Geliefert am 07. Juli 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land & buildings on the north side of hampstead avenue mildenhall industrial estate mildenhall suffolk t/no SK132130 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 11. Aug. 1993 Geliefert am 16. Aug. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Aug. 1988 Geliefert am 05. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or sloane group (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 1986 Geliefert am 27. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit D3 clock close earls barton, northampton, northamptonshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 31. Okt. 1986 Geliefert am 05. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed. | |
Kurze Angaben F/H land and buildings erected thereon k/a unit D3 clock close industrial estate, earls barton, northamptonshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Sub-mortgage | Erstellt am 16. Apr. 1986 Geliefert am 07. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit D6 baron avenue, earls barton, northants. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Apr. 1981 Geliefert am 22. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or display enterprises LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of charge. | Erstellt am 17. Mai 1972 Geliefert am 01. Juni 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from display enterprises LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any accounts of the company whether current accounts on deposit accounts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SLOANE GROUP (HOLDINGS) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0