ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00712831
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    E & G ESTATES LIMITED22. Jan. 199022. Jan. 1990
    ESTATES AND GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    S.E.E.DEVELOPMENTS(BEDFORD)LIMITED12. Jan. 196212. Jan. 1962

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2018

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2018

    22 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. Sept. 2017

    2 Seiten3.6

    Beendigung der Bestellung von F & C Reit (Corporate Services) Limited als Sekretär am 08. Aug. 2017

    2 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2017

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2017

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. Sept. 2016

    1 Seiten3.6

    Beendigung der Bestellung von Christopher George White als Geschäftsführer am 11. Apr. 2016

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2016

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2016

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. Sept. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2015

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. Sept. 2014

    3 Seiten3.6

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England zum C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR am 26. Sept. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2014

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2014

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2013

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2013

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. Sept. 2012

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. März 2012

    3 Seiten3.6

    Wer sind die Geschäftsführer von ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Sekretär
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Sekretär
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3143222
    79571870006
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    TAYLOR, Robert Patrick
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish7862560003
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Tenth supplemental trust deed
    Erstellt am 12. Mai 2006
    Geliefert am 15. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Certain houses and shops bearing the numbers 17 and a half, 19 and 21 ''beresford street'' in the parish of st helier vingtaine de haut de la ville in the island of jersey by way of floating charge its undertaking and all its property and assets present and future wheresoever including any uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 215. März 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 210. Juni 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 210. Juni 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 24. Aug. 1998
    Geliefert am 25. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Kurze Angaben
    F/H hayle business park and land adjoining marsh lane hayle cornwall t/n-CL65486 and all property k/a bluebell estate acklam middlesborough cleveland being all that f/h land being 5 to 15A medina gardens 2 to 10A romanby gardens and 13 to 11A lowlane acklam t/n-CE70014 (see form 395 for full details of property charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 1992
    Geliefert am 24. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates & general PLC and/or the company to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gardens and other properties (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 1992
    Geliefert am 17. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and by estates & general PLC to the governor and company of the bank of scotland
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a plots 87-94 (inclusive) 100 102 104 and 110-113 (inclusive) the croft water lane cornwall.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 1992
    Geliefert am 17. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and estates & general PLC to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a hayle industrial park and hayle retail park marsh lane hayle cornwall other than plots 3 9 15 and 16 hayle industrial park and an area of 7. 92 square metres.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 04. Aug. 1992
    Geliefert am 19. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties (all as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1992
    Geliefert am 04. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property at marsh lane,hayle,cornwall and k/a hayle ind' park & retail park see doc M284C for details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1992
    Geliefert am 04. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gdns',and 2-30A samaria gdns',acklam,middlesborough.t/n CE70053 5-15A medina gdns',2-10A romanby gdns' & 3-11 low lane,acklam,middlesborough.t/n CR70014.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1992
    Geliefert am 04. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a plots 87-94,100,102,104,and 110-113 the croft,water lane,hayle,cornwall.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juli 1998Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Dez. 1991
    Geliefert am 31. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 53-56 bartholomew street, land at 1 st. Nicholas street and st. Michaels road, newbury, berkshire title nos. BK260821 and BK280608.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. März 1991
    Geliefert am 22. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    16,18 and 20 bridge street, leatherhead and land adjoining 20 bridge street leatherhead and/or the proceeds of sale thereof t/n sy 336363, sy 485260, sy 357147 and sy 446734. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable charge
    Erstellt am 26. Juli 1990
    Geliefert am 13. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates and general PLC to the chargee
    Kurze Angaben
    Prestwood house high wycombe.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable charge
    Erstellt am 26. Juli 1988
    Geliefert am 27. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H property k/a ward house, corporation street and castle street, high wycombe.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Jan. 1987
    Geliefert am 29. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from estates and general investments public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 54/56 high street alfreton derbyshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Nov. 1986
    Geliefert am 11. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 14,20,22,24 & 26 south street, dorking in the district of mole valley, surrey title no sy 485678 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 1984
    Geliefert am 31. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property known as blocks a and b, second way avonmouth industrial estate, avonmouth title no av 90348 and av 90349 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 1984
    Geliefert am 31. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H mccelland house, (formerly the power house) headstone lane, harrow. Title no ngl 248936 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juni 1983
    Geliefert am 28. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a little horwood manor nr bletchley, bucks and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Mai 1983
    Geliefert am 06. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Second third, and fourth floors 18, 18A and 18B white lion street, norwich, norfolk.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Mai 1983
    Geliefert am 16. Mai 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Castle hotel, castle meadow, norwich, norfolk title no:- nk 42785. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Mai 1983Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1981
    Geliefert am 28. Mai 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H k/a brook way leatherhead surrey title nos sy 327047 and sy 357185.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1982Registrierung einer Belastung
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Jan. 2011Beginn der Liquidation
    04. Jan. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Receiver Manager
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Receiver Manager
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Receiver Manager
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0