HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00713226 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
- Herstellung von Öfen, Hochöfen und Brennern (28210) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O TENEO FINANCIAL ADVISORY LIMITED The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
POWELL DUFFRYN CASTINGS LIMITED | 12. Okt. 1983 | 12. Okt. 1983 |
HAMWORTHY OIL BURNING LIMITED | 18. Jan. 1962 | 18. Jan. 1962 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT am 20. Mai 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2022 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 17. Nov. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 7 Albemarle Street London W1S 4HQ verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 7 Albemarle Street London W1S 4HQ United Kingdom zum 7 Albemarle Street London W1S 4HQ geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Fleets Corner Poole Dorset BH17 0LA zum C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN am 08. Jan. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 15 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Nov. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Koch Chemical Technology Group Limited as a person with significant control on 30. Sept. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 34 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 100 New Bridge Street London EC4V 6JA zum 7 Albemarle Street London W1S 4HQ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWMAN, Paul Richard | Sekretär | 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham The Colmore Building | 241601700001 | |||||||
CHAMBERS, Casey Jay | Geschäftsführer | E. Apache Tulsa 11920 Ok 74116 United States | United States | American | Business Executive | 205143860001 | ||||
COUCEIRO, Eduardo Emilio | Geschäftsführer | Zone Industrielle Riedgen L 3401 Dude Lange B.P 83 Luxembourg | France | Italian | Finance Controller | 161540850001 | ||||
NEWMAN, Paul Richard | Geschäftsführer | 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham The Colmore Building | United Kingdom | British | Business Executive | 66782150001 | ||||
SAIA, Anthony | Geschäftsführer | 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham The Colmore Building | United Kingdom | British | Director | 138685580002 | ||||
BARLOW, Alan Thomas | Sekretär | Annes Bunch Lane GU27 1AE Haslemere Surrey | English | Company Director | 13735800001 | |||||
BUTLER, Anthony Edgar | Sekretär | 1 Laurel Gardens BH18 8LT Broadstone Dorset | British | Company Director | 42851610002 | |||||
LANARY, Roger Shaun | Sekretär | 6 Lower Blandford Road SP7 8NR Shaftesbury Dorset | British | Director | 105361450001 | |||||
PRICE, Richard James | Sekretär | Fleets Corner Poole BH17 0LA Dorset | 210066500001 | |||||||
RICHARDSON, Geoffrey | Sekretär | 173 Golf Links Road BH22 8BX Ferndown Dorset | British | 3231480001 | ||||||
SAIA, Anthony | Sekretär | Fleets Corner Poole BH17 0LA Dorset | British | 138685580001 | ||||||
BARLOW, Alan Thomas | Geschäftsführer | Annes Bunch Lane GU27 1AE Haslemere Surrey | England | English | Company Director | 13735800001 | ||||
BURKE, Rex | Geschäftsführer | 6 Water Tower Road BH18 8LL Broadstone Dorset | British | Company Director | 30356710001 | |||||
BUTLER, Anthony Edgar | Geschäftsführer | 1 Laurel Gardens BH18 8LT Broadstone Dorset | British | Company Director | 42851610002 | |||||
CAHILL, John Antony | Geschäftsführer | Windsong Broomhill BH21 7AR Wimborne Dorset | British | Company Director | 10923330001 | |||||
ELLIS, Norman Arthur | Geschäftsführer | 14 Poplar Close BH21 1TL Wimborne Dorset | British | Director | 28178140001 | |||||
GISSEL, Peter | Geschäftsführer | Damansara 29a Abbotswood GU1 1UZ Guildford Surrey | England | Danish | Chartered Accountant | 66093140002 | ||||
GOODMAN, Jimmy Dean | Geschäftsführer | E. Apache 19801 Tulsa 11920 Ok 74121 United States | Usa | United States | Businessman | 161541120001 | ||||
HARRIS, Stephen Clive | Geschäftsführer | Northolt Thames Street TW16 6AG Sunbury On Thames Middlesex | United Kingdom | British | Director | 114556470001 | ||||
HAYES, Alexander Meredith | Geschäftsführer | 58 Bawnmore Road CV22 7QW Rugby Warwickshire | England | British | Director | 100436730001 | ||||
INGRAM, Richard Frederick | Geschäftsführer | 60 Richard Cottage The Bight, Charlton WR10 3LF Pershore Worcestershire | British | Spares Service Director | 97957800001 | |||||
IVETT, Christopher Peter | Geschäftsführer | Fleets Corner Poole BH17 0LA Dorset | United Kingdom | British | Director | 113448230002 | ||||
JUDDERY, Angela Mary | Geschäftsführer | 111 Surrey Road Branksome BH12 1HQ Poole Dorset | England | British | Accountant | 90954600001 | ||||
LANARY, Roger Shaun | Geschäftsführer | 6 Lower Blandford Road SP7 8NR Shaftesbury Dorset | United Kingdom | British | Director | 105361450001 | ||||
LEA, Andrew James | Geschäftsführer | 8 Gauden Road Clapham SW4 6LT London Flat 2 | England | British | Investment Banker | 131902510001 | ||||
MILLER, Peter Barrie | Geschäftsführer | 470 Mica Court Shelton Ct 06484 Connecticut Usa | Canadian | Company Director | 41650260002 | |||||
NOAKES, Michael | Geschäftsführer | Arden House 72 Hamilton Road HP13 5BQ High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1534620001 | |||||
PARDON, Alan William | Geschäftsführer | Hill View Alweston, Alweston DT9 5JR Sherborne Dorset | England | British | Director | 109722740001 | ||||
POWELL, John | Geschäftsführer | 5 Hedgerley Becton Green Becton Lane Barton-On-Sea Dorset | British | Company Director | 10923340001 | |||||
PRICE, Richard James | Geschäftsführer | Fleets Corner Poole BH17 0LA Dorset | United Kingdom | British | Business Executive | 209993700001 | ||||
RICHARDSON, Geoffrey | Geschäftsführer | 173 Golf Links Road BH22 8BX Ferndown Dorset | United Kingdom | British | Company Director | 3231480001 | ||||
SODEN, John Francis | Geschäftsführer | 98 Alleyn Road Dulwich SE21 8AH London | England | British | Investment Banker | 68179870002 | ||||
TESTER, Rodney Michael | Geschäftsführer | 7 Sara Park DA12 4SB Gravesend Kent | British | Director | 57859400002 | |||||
WIGNALL, Michael Frederick | Geschäftsführer | 64 Chine Walk West Parley BH22 8PX Ferndown Dorset | England | British | Company Director | 38638240002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch Engineered Solutions Limited | 06. Apr. 2016 | Fenton ST4 2LT Stoke-On-Trent King Street Staffordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Sept. 2004 Geliefert am 25. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A first supplemental deed between amongst others, the company and deutsche bank ag london as security agent (as defined) (supplemental to a composite guarantee and debenture dated 21 december 2000 between amongst others, the company and the security agent) | Erstellt am 13. März 2001 Geliefert am 23. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the security agent (as defined), to deutsche bank ag london as senior arranger, securitisation bridge arranger, lng arranger, to deutsche bank ag london and/or all and any under lenders participating in the working capital facility the senior facilities agreement (as defined) and pursuant to various documents and agreements (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture between amongst others, the company and deutsche bank ag london as security agent (as defined) | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 02. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the security agent (as defined), to deutsche bank ag london as senior arranger, securitisation bridge arranger, lng arranger, to deutsche bank ag london and/or all and any lenders participating in the working capital facility under the senior facilities agreement (as defined) and pursuant to various documents and agreements (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental trust deed | Erstellt am 21. Aug. 1962 Geliefert am 10. Sept. 1962 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing £600,000 debenture stock of hamworthy engineering LTD. Secured by a trust deed dated 21ST july 1961 and an increased rate of intrst thereon. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat HAMWORTHY COMBUSTION ENGINEERING LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0