CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00727277 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | First Floor River Court The Old Mill Office Park Mill Lane GU7 1EZ Godalming Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LONDON & CLEVELAND PROPERTIES LIMITED | 08. Aug. 1994 | 08. Aug. 1994 |
| LINNET PROPERTY COMPANY LIMITED | 29. Juli 1994 | 29. Juli 1994 |
| LINNET PROPERTY COMPANY LIMITED | 20. Juni 1962 | 20. Juni 1962 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Luke Kevin Andrews als Sekretär am 16. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 5 Seiten | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Dominic Akers-Douglas als Direktor am 02. Juni 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Loudon Constantine als Geschäftsführer am 02. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Nigel Kenrick Grosvenor Prescot als Direktor am 31. Dez. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift First Floor River Court the Old Mill Office Park Mill Lane Godalming Surrey GU7 1EZ verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Loudon Constantine am 20. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKERS-DOUGLAS, Dominic Lovett | Geschäftsführer | Coach Road Shopwhyke PO20 2BG Chichester Shopwyke Manor West Sussex | England | British | 142219010023 | |||||
| PRESCOT, Nigel Kenrick Grosvenor | Geschäftsführer | Linchmere GU27 3NF Haslemere Danley Farm Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 70918800001 | |||||
| ANDREWS, Luke Kevin | Sekretär | The Old Mill Office Park Mill Lane GU7 1EZ Godalming First Floor River Court Surrey | 189157030001 | |||||||
| ATTER, Douglas John | Sekretär | 7 Welbeck Gardens MK41 8RW Bedford Bedfordshire | British | 4993620002 | ||||||
| KEEBLE, Simon John | Sekretär | Four Winds Horsell Park Close GU21 4LZ Woking Surrey | British | 33679960001 | ||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Thames House Portsmouth Road KT10 9AD Esher Surrey | 34893920004 | |||||||
| CONSTANTINE, Joseph | Geschäftsführer | 9 Canning Place W8 5AD London | British | 16916160002 | ||||||
| CONSTANTINE, Nigel Loudon | Geschäftsführer | Queens Street Stedham GU29 0NW Midhurst Westbrook West Sussex England | England | British | 2988440007 | |||||
| COPE, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | 20 Sandy Mount Bearsted ME14 4PJ Maidstone Kent | British | 2988420001 | ||||||
| HIGGITT, Andrew Christian | Geschäftsführer | 48 Pewley Way GU1 3QA Guildford Surrey | England | English | 26240470001 | |||||
| KEEBLE, Simon John | Geschäftsführer | Four Winds Horsell Park Close GU21 4LZ Woking Surrey | British | 33679960001 | ||||||
| MAGEE, Edward | Geschäftsführer | Brown Rigg Sandy Bank NE44 6HT Riding Mill Northumberland | British | 53731230001 | ||||||
| SIMSON, John Henry Francis | Geschäftsführer | 36 Thurloe Square SW7 2SR London | British | 2988460001 | ||||||
| SUTTON, Timothy James | Geschäftsführer | Blandford House 4 Blandford Close GU22 7EJ Woking Surrey | British | 47956280001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantine Group Plc | 06. Apr. 2016 | The Old Mill Office Park Mill Lane GU7 1EZ Godalming First Floor River Court Surrey United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Aug. 1999 Geliefert am 26. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 1-5 winchester street salisbury wiltshire t/n-WT95249.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juli 1999 Geliefert am 02. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever but notwithstanding anything contained threin to the contrary it is hereby expressly agreed and declared that the security hereby constituted shall be enforceable only in respect of the liabilities of the company to the bank under the terms of a guarantee dated 8 july 1999 to secure the liabilities of london & cleveland (aldridge) limited to the bank | |
Kurze Angaben Land and buildings at sheffield road sheepbridge chesterfield derbyshire t/n DY244913 and DY130931. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Okt. 1997 Geliefert am 17. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property situate in gatehouse lane burgess hill east sussex t/no;-WSX199229. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Okt. 1997 Geliefert am 17. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 7-11 winchester street salisbury wiltshire t/no;-WT137085 and WT105142. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Apr. 1997 Geliefert am 30. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property k/a basildon court marylebone high street london borough of city of westminster t/n NGL340778 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 21. Nov. 1996 Geliefert am 06. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property units a & b locksbrook road bath t/no AV39149 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 21. Nov. 1996 Geliefert am 06. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H wellington place bletchley bucks t/no BM159059 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Jan. 1994 Geliefert am 17. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from constantine holdings limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a part of george house 61 63 and 65 kensington church street kensington t/no.NGL213977 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Jan. 1994 Geliefert am 17. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from london and cleveland estates limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a units a and b locksbrook road, weston, bath, avon t/no.AV39149 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0