CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED

CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00727277
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    First Floor River Court The Old Mill Office Park
    Mill Lane
    GU7 1EZ Godalming
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LONDON & CLEVELAND PROPERTIES LIMITED08. Aug. 199408. Aug. 1994
    LINNET PROPERTY COMPANY LIMITED 29. Juli 199429. Juli 1994
    LINNET PROPERTY COMPANY LIMITED 20. Juni 196220. Juni 1962

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. März 2016

    Kapitalaufstellung am 29. März 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Luke Kevin Andrews als Sekretär am 16. Dez. 2015

    1 SeitenTM02

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 SeitenRP04
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Okt. 2015Clarification Second filing AP01 for Dominic Akers-Douglas.

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2014

    7 SeitenAA

    Ernennung von Mr Dominic Akers-Douglas als Direktor am 02. Juni 2015

    3 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Okt. 2015Clarification A second filed AP01 was registered on 07/10/2015.

    Beendigung der Bestellung von Nigel Loudon Constantine als Geschäftsführer am 02. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. März 2015

    Kapitalaufstellung am 03. März 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Ernennung von Mr Nigel Kenrick Grosvenor Prescot als Direktor am 31. Dez. 2013

    2 SeitenAP01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift First Floor River Court the Old Mill Office Park Mill Lane Godalming Surrey GU7 1EZ verlegt

    1 SeitenAD04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Loudon Constantine am 20. Aug. 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AKERS-DOUGLAS, Dominic Lovett
    Coach Road
    Shopwhyke
    PO20 2BG Chichester
    Shopwyke Manor
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Coach Road
    Shopwhyke
    PO20 2BG Chichester
    Shopwyke Manor
    West Sussex
    EnglandBritish142219010023
    PRESCOT, Nigel Kenrick Grosvenor
    Linchmere
    GU27 3NF Haslemere
    Danley Farm
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Linchmere
    GU27 3NF Haslemere
    Danley Farm
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish70918800001
    ANDREWS, Luke Kevin
    The Old Mill Office Park
    Mill Lane
    GU7 1EZ Godalming
    First Floor River Court
    Surrey
    Sekretär
    The Old Mill Office Park
    Mill Lane
    GU7 1EZ Godalming
    First Floor River Court
    Surrey
    189157030001
    ATTER, Douglas John
    7 Welbeck Gardens
    MK41 8RW Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    7 Welbeck Gardens
    MK41 8RW Bedford
    Bedfordshire
    British4993620002
    KEEBLE, Simon John
    Four Winds
    Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Sekretär
    Four Winds
    Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British33679960001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    Sekretär
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    34893920004
    CONSTANTINE, Joseph
    9 Canning Place
    W8 5AD London
    Geschäftsführer
    9 Canning Place
    W8 5AD London
    British16916160002
    CONSTANTINE, Nigel Loudon
    Queens Street
    Stedham
    GU29 0NW Midhurst
    Westbrook
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    Queens Street
    Stedham
    GU29 0NW Midhurst
    Westbrook
    West Sussex
    England
    EnglandBritish2988440007
    COPE, Peter Geoffrey
    20 Sandy Mount
    Bearsted
    ME14 4PJ Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    20 Sandy Mount
    Bearsted
    ME14 4PJ Maidstone
    Kent
    British2988420001
    HIGGITT, Andrew Christian
    48 Pewley Way
    GU1 3QA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    48 Pewley Way
    GU1 3QA Guildford
    Surrey
    EnglandEnglish26240470001
    KEEBLE, Simon John
    Four Winds
    Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Four Winds
    Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British33679960001
    MAGEE, Edward
    Brown Rigg Sandy Bank
    NE44 6HT Riding Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Brown Rigg Sandy Bank
    NE44 6HT Riding Mill
    Northumberland
    British53731230001
    SIMSON, John Henry Francis
    36 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    Geschäftsführer
    36 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    British2988460001
    SUTTON, Timothy James
    Blandford House 4 Blandford Close
    GU22 7EJ Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Blandford House 4 Blandford Close
    GU22 7EJ Woking
    Surrey
    British47956280001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    The Old Mill Office Park
    Mill Lane
    GU7 1EZ Godalming
    First Floor River Court
    Surrey
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    The Old Mill Office Park
    Mill Lane
    GU7 1EZ Godalming
    First Floor River Court
    Surrey
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00649369
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CONSTANTINE HOLDINGS (2008) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Aug. 1999
    Geliefert am 26. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 1-5 winchester street salisbury wiltshire t/n-WT95249.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juli 1999
    Geliefert am 02. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever but notwithstanding anything contained threin to the contrary it is hereby expressly agreed and declared that the security hereby constituted shall be enforceable only in respect of the liabilities of the company to the bank under the terms of a guarantee dated 8 july 1999 to secure the liabilities of london & cleveland (aldridge) limited to the bank
    Kurze Angaben
    Land and buildings at sheffield road sheepbridge chesterfield derbyshire t/n DY244913 and DY130931.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Okt. 1997
    Geliefert am 17. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property situate in gatehouse lane burgess hill east sussex t/no;-WSX199229. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Okt. 1997
    Geliefert am 17. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 7-11 winchester street salisbury wiltshire t/no;-WT137085 and WT105142. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1997
    Geliefert am 30. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a basildon court marylebone high street london borough of city of westminster t/n NGL340778 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Nov. 1996
    Geliefert am 06. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property units a & b locksbrook road bath t/no AV39149 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Nov. 1996
    Geliefert am 06. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H wellington place bletchley bucks t/no BM159059 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from constantine holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a part of george house 61 63 and 65 kensington church street kensington t/no.NGL213977 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Jan. 1994
    Geliefert am 17. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from london and cleveland estates limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units a and b locksbrook road, weston, bath, avon t/no.AV39149 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0