FAVOR PARKER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFAVOR PARKER LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00733060
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FAVOR PARKER LIMITED?

    • Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere (10910) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich FAVOR PARKER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAVOR PARKER LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2014
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2015
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FAVOR PARKER LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis17. Aug. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung31. Aug. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FAVOR PARKER LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für FAVOR PARKER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation

    3 SeitenREST-MVL

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Nov. 2016

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Apr. 2016

    38 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5Th Floor 6 St. Andrew Street London England and Wales EC4A 3AE zum C/O Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU am 06. Mai 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Apr. 2015

    LRESSP

    Verschiedenes

    Section 519 companies act 2006
    1 SeitenMISC

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 24. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 1.00
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share capital redemption reserve reduced 23/02/2015
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    11 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 2,800,400
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 09. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 2,800,400
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Peter Miller als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Leon Barry Abbitt als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Steven als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Louis Vernaus als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Maarten Kusters als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von FAVOR PARKER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish153119640001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Sekretär
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    British194640001
    TROLLOPE, Barry Desmond
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    Sekretär
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    British45609870001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Sekretär
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Sekretär
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Sekretär
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ALLEN, Geoffrey Gordon
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    British15877490001
    BARTON, Eric Anthony
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish1323220001
    BOARDALL, Keith
    The Old Parsonage
    Baldersby St James
    YO7 4PT Thirsk
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Parsonage
    Baldersby St James
    YO7 4PT Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritish32617840001
    CARTER, David
    Blendworth Crowborough Hill
    TN6 2SD Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Blendworth Crowborough Hill
    TN6 2SD Crowborough
    East Sussex
    British62696360001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    COLE, Christopher Dale
    The Nook
    Honeypot Lane Wattisfield
    IP22 1PA Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Nook
    Honeypot Lane Wattisfield
    IP22 1PA Diss
    Norfolk
    British32393790001
    COLE, Christopher Dale
    The Nook
    Honeypot Lane Wattisfield
    IP22 1PA Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Nook
    Honeypot Lane Wattisfield
    IP22 1PA Diss
    Norfolk
    British32393790001
    COLES, Philip Charles John
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    Geschäftsführer
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    British47148220001
    DENTON, Alban Bede
    Park House
    Westfield Road
    KY15 5DR Cupar
    Fife
    Geschäftsführer
    Park House
    Westfield Road
    KY15 5DR Cupar
    Fife
    British67184980004
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    FOX, Garrick Thomas
    Kiln Cottage
    Syleham
    IP21 4LT Eye
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Kiln Cottage
    Syleham
    IP21 4LT Eye
    Suffolk
    EnglandBritish15836150001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Geschäftsführer
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    HALL, Michael James
    12 Cherry Orchard
    Holt
    LL13 9AH Wrexham
    Geschäftsführer
    12 Cherry Orchard
    Holt
    LL13 9AH Wrexham
    British89996450001
    HITCHINS, Christopher Thomas
    53 Church Road
    Wimbotsham
    PE34 3QG Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    53 Church Road
    Wimbotsham
    PE34 3QG Kings Lynn
    Norfolk
    British36473880001
    HITCHINS, Christopher Thomas
    53 Church Road
    Wimbotsham
    PE34 3QG Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    53 Church Road
    Wimbotsham
    PE34 3QG Kings Lynn
    Norfolk
    British36473880001
    HOLMES, William Brian
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    British15877510001
    HOPLEY, Philip Thomas
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    British957150007
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutch167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    MCDONALD, Peter Thomas
    78 Ingram Court
    Norwich
    WR1 2HQ Norfolk
    Geschäftsführer
    78 Ingram Court
    Norwich
    WR1 2HQ Norfolk
    British45335590006
    MILLER, Peter John
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritish55542610002
    MURPHY, Andrew Blyth
    Pitlessie House
    Cupar Road, Pitlessie
    KY15 7SU Fife
    Geschäftsführer
    Pitlessie House
    Cupar Road, Pitlessie
    KY15 7SU Fife
    ScotlandBritish89996470002
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARKER, John Gordon
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    British15877480001
    PARKER, Michael Joseph Bennett
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    British12897020001
    PARKER, Michael Joseph Bennett
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    British12897020001
    PARKER, Stephen Favor
    The Barn House
    Hythe Road Foulden
    IP26 5AH Thetford
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Barn House
    Hythe Road Foulden
    IP26 5AH Thetford
    Norfolk
    EnglandBritish15877500004

    Hat FAVOR PARKER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second ranking security agreement (assignment of receivables)
    Erstellt am 02. Okt. 2012
    Geliefert am 15. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any subordinated secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Nov. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First ranking security agreement (assignment of receivables)
    Erstellt am 02. Okt. 2012
    Geliefert am 15. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any senior secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Nov. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An intercreditor and security agreement
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 13. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transaktionen
    • 13. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Mai 2007
    Geliefert am 08. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 23. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares mortgage
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 14. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cmpany to the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All shares,dividends payable and all stocks,securities,rights,moneys or property accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 14. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Aug. 1996
    Geliefert am 09. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums of money or liabilities which now are or which may at any time or from time to time be or become due to the chargee and the banks (as therein defined) (or any of them) by the company or for which the company is or may be at any time or from time to time be or become liable or responsible to the chargee and the banks (or any of them) in any manner or way or in any respect whatsoever or in connection with or arising out of any financing document, or out of any other current or other account, order, cheque, note, draft, bill, promissory note, letter of credit or guarantee (whether granted by the chargee or a bank on the company's behalf or by the company to the chargee or a bank) or any one or more of any such or otherwise whatsoever.
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a chettisham extrusion facility lynn road, chettisham,ely, cambs., L/h property k/a methwold store, methwold airfield, brandon road, methwold and f/h property k/a stoke ferry grainstore, furlong road, stoke ferry, norfol. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandehalf of the Banksfor Itself and as Agent and Trustee for and on B
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares mortgage
    Erstellt am 23. Aug. 1996
    Geliefert am 09. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums of money or liabilities which now are or which may at any time or from time to time be or become due to the chargee and the banks (as therein defined) (or any of them) by the company or for which the company is or may be at any time or from time to time be or become liable or responsible to the chargee and the banks (or any of them) in any manner or way or in any respect whatsoever or in connection with or arising out of any financing document, or out of any other current or other account, order, cheque, note, draft, bill, promissory note, letter of credit or guarantee (whether granted by the chargee or a bank on the company's behalf or by the company to the chargee or a bank) or any one or more of any such or otherwise whatsoever.
    Kurze Angaben
    All dividends paid or payable after the date of the shares mortgage on all or any of the shares in sovereign food group limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandehalf of the Banksfor Itself and as Agent and Trustee for and on B
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1992
    Geliefert am 11. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 27. Mai 1983
    Geliefert am 10. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 1ST may 1983
    Kurze Angaben
    Third floating charge over all undertaking and all property present and future including uncalled capital third fixed charge over book debts.
    Berechtigte Personen
    • Fitch Lovell Public Limited Company
    Transaktionen
    • 10. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 27. Mai 1983
    Geliefert am 06. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts & uncalled capital. With all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 27. Mai 1983
    Geliefert am 03. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 11.10.77 and deeds supplemental thereto.
    Kurze Angaben
    All book debts & other debts present & future. (See doc. M77).
    Berechtigte Personen
    • F F I (UK Finance) Public Limited Company.
    Transaktionen
    • 03. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on shares.
    Erstellt am 14. Nov. 1980
    Geliefert am 03. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Further securing all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a debenture dated 11 october 1977 & all other sums intended to the thereby & hereby secured.
    Kurze Angaben
    Equitable charge on the whole of the share capital of favor parker chickens limited.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 11. Okt. 1977
    Geliefert am 17. Okt. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies advanced under an agreement dtd 11-10-77 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    Goodwill, bookdebts, stock in trade, work in progress with all buildings and fixtures in the nature of land lords fixtures present and future. The companys freehold and leasehold property as described in doc. M71. fixed and floating charge. (Please see doc. M71 for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1977Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 10. Dez. 1964
    Geliefert am 23. Dez. 1964
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc
    Kurze Angaben
    Premises at stoke ferry norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1964Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 28. Sept. 1963
    Geliefert am 03. Okt. 1963
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking, and goodwill, all property, plant, machinery, fixtures & assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1963Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FAVOR PARKER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Feb. 2017Soll aufgelöst werden am
    10. Apr. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0