DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00733686 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Wales |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DISPLAYMATICS LIMITED | 28. Aug. 1962 | 28. Aug. 1962 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Zane Cedomir Mersich am 11. Jan. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales zum Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Zane Cedomir Mersich am 22. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales zum Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB am 13. Juli 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England zum Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB am 16. März 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Neil Paramore als Sekretär am 28. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Neil Paramore als Geschäftsführer am 28. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Andrew Mark Glennon als Sekretär am 28. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Andrew Mark Glennon als Direktor am 28. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Juni 2016 | 6 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLENNON, Andrew Mark | Sekretär | South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Novomatic House Wales | 266960890001 | |||||||
| GLENNON, Andrew Mark | Geschäftsführer | South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Novomatic House Wales | Wales | British | 260666740001 | |||||
| MERSICH, Zane Cedomir | Geschäftsführer | South Road Bridgend Indsutrial Estate CF31 3EB Bridgend Novomatic House Wales | England | South African | 131382980002 | |||||
| HARVEY, Peter James | Sekretär | 3 Gates Court High Street SG7 6GA Baldock Hertfordshire | British | 103770410001 | ||||||
| PARAMORE, Neil | Sekretär | Kingsway Bridgend Industrial Estate CF31 3RY Bridgend Astra House Mid Glamorgan Wales | 209557760001 | |||||||
| SHEERIN, Clare | Sekretär | 8 College Place SO15 2FF Southampton Hampshire | British | 116312770001 | ||||||
| WILLSON, Michael Eric Anthony | Sekretär | 8 Chestnut Close Chandlers Ford SO53 3HH Eastleigh Hampshire | British | 7439200002 | ||||||
| WILSON, Karen | Sekretär | Woodlands Business Park Linford Wood MK14 6EW Milton Keynes Birch House Buckinghamshire United Kingdom | British | 151965170002 | ||||||
| YANTIN, Gary Laurence | Sekretär | 85 Cardinal Avenue WD6 1ST Borehamwood Hertfordshire | British | 119004760001 | ||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Black Friars Lane EC4V 6HD London 20 | 39182980001 | |||||||
| GUYER, John Hugh | Geschäftsführer | Thatched Cottage Greatbridge SO51 0HB Romsey Hampshire | British | 35529950003 | ||||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||
| HARDING, Nicholas Simon | Geschäftsführer | The Old Wharf House The Wharf MK14 5AS Great Linford Buckinghamshire | England | British | 150860820001 | |||||
| HARVEY, Peter James | Geschäftsführer | Woodlands Business Park Linford Wood MK14 6EW Milton Keynes Birch House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 103770410003 | |||||
| PARAMORE, Neil | Geschäftsführer | 1 Kingsway Bridgend Industrial Estate CF31 3RY Bridgend Astra House Mid Glamorgan Wales | Wales | British | 79707840002 | |||||
| REDMOND, Brendan Patrick | Geschäftsführer | 57 Crisp Street 3188 Hampton Victoria 3188 Australia | Australia | Irish | 117576220001 | |||||
| WILLSON, Michael Eric Anthony | Geschäftsführer | 8 Chestnut Close Chandlers Ford SO53 3HH Eastleigh Hampshire | England | British | 7439200002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talarius Ltd | 06. Apr. 2016 | Breckland Linford Wood MK14 6EW Milton Keynes Birch House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 04. Apr. 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 08. Feb. 2007 Geliefert am 14. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Okt. 2006 Geliefert am 19. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 2000 Geliefert am 23. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 bellvue road southampton. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 13. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a 1 the broadway portswood southampton hampshire t/ HP281708. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Jan. 1997 Geliefert am 23. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 61 commercial road totton southampton hampshire t/no hp 407319 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Aug. 1993 Geliefert am 26. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £86,450 and all other moneys due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 1 the broadway portswood southampton hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 03. Juni 1992 Geliefert am 08. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 30 and 32 high road,swaythling,southampton,hampshire.t/nos. Hp 178279 and hp 129297 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Dez. 1987 Geliefert am 17. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h and l/h property k/a 208 burgess road, southampton and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Okt. 1983 Geliefert am 17. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 32/34 beech road millbrook southampton t/n:- HP147635 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 1983 Geliefert am 17. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 110A bevois valley road, southampton t/n:- HP171846. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 1983 Geliefert am 10. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H eatamasan cafe and adjaning premises at 1A & 1B weston lane woolston, southampton.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Aug. 1980 Geliefert am 10. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 27,000 | |
Kurze Angaben 32/34 beech road, millbrook southampton, hampshire 110A bevois valley road southampton, hampshire. | ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral legal charge | Erstellt am 03. März 1980 Geliefert am 10. M ärz 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 7,000.00 | |
Kurze Angaben 110A bevois valley rd southampton, hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral legal charge | Erstellt am 03. März 1980 Geliefert am 10. März 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 7,000.00 | |
Kurze Angaben 23/34 beech rd, millbrook southampton, hampshire T. no. HP147635. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0