SURRIDGE DAWSON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSURRIDGE DAWSON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00744679
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SURRIDGE DAWSON LIMITED?

    • (5156) /

    Wo befindet sich SURRIDGE DAWSON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O ERNST & YOUNG LLP
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SURRIDGE DAWSON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Sept. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für SURRIDGE DAWSON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2017

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2017

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2016

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2015

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2014

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2012

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2011

    10 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Nigel Freer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Adrian Wood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Hugh Cawley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Adrian Wood als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Hinweis auf die Gründung des Liquidationsausschusses

    2 Seiten4.48

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Wer sind die Geschäftsführer von SURRIDGE DAWSON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARK, William David
    5 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Sekretär
    5 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British21438440001
    WOOD, Adrian Lewis
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British53930680002
    ARDEN, Philip John
    99 Hodford Road
    NW11 8EH London
    Geschäftsführer
    99 Hodford Road
    NW11 8EH London
    EnglandUnited KingdomFinance Director72635300002
    BAKER, Dennis Henry
    3a Hillcrest Road
    Saltwood
    CT21 5EX Hythe
    Kent
    Geschäftsführer
    3a Hillcrest Road
    Saltwood
    CT21 5EX Hythe
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant8558620001
    BLUNDELL, David
    38 Rue Des Armateurs
    17350 Port D'Envaux
    Charente Maritime
    France
    Geschäftsführer
    38 Rue Des Armateurs
    17350 Port D'Envaux
    Charente Maritime
    France
    FranceBritishChief Operating Officer135612830001
    BROWN, Jeffrey Richard
    Greenway Cottage
    2 Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Greenway Cottage
    2 Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    Kent
    BritishMarketing Director33494270001
    BROWN, Peter Michael
    12 Hyde Park Place
    W2 2LH London
    Geschäftsführer
    12 Hyde Park Place
    W2 2LH London
    EnglandBritishAccountant1788540001
    BUTTERWORTH, Paul
    Slade Leas
    Middleton Cheney
    OX17 2NH Banbury
    10
    Oxon
    Geschäftsführer
    Slade Leas
    Middleton Cheney
    OX17 2NH Banbury
    10
    Oxon
    United KingdomBritishDirector133099190001
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector41820960003
    CONNOLLY, Gerard Vincent
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    IrishDirector57063820001
    DURANCE, Peter George
    132 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Geschäftsführer
    132 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    BritishRetired Wholesale Ne63568700001
    EVAN-COOK, Paul
    Borderigg Benhall Mill Road
    TN2 5JH Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Borderigg Benhall Mill Road
    TN2 5JH Tunbridge Wells
    Kent
    BritishFinance Director7658310001
    FREER, Nigel Rodney
    The Drey 12 Lakewood Road
    Chandlers Ford
    SO53 1ES Eastleigh
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Drey 12 Lakewood Road
    Chandlers Ford
    SO53 1ES Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector59149820004
    HADDON, Laurence Lyndon
    Walnut Lea Beacon Hill
    Penn
    HP10 8NH High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Walnut Lea Beacon Hill
    Penn
    HP10 8NH High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director7817410001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector50619920001
    HAVELL, Roger Laurence
    1 Hatchlands
    Broad Street
    RH17 5LS Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    1 Hatchlands
    Broad Street
    RH17 5LS Haywards Heath
    West Sussex
    British73794670001
    HOWE, John
    10 Primrose Lane
    RG41 5UR Winnersh
    Berkshire
    Geschäftsführer
    10 Primrose Lane
    RG41 5UR Winnersh
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector72001440001
    INGLEBY, Bryan Clifford
    Wentworth 355 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    Geschäftsführer
    Wentworth 355 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    BritishChief Executive7658300001
    KENNEDY, Alan Gilbert
    PO BOX 561 Pmb 6/805
    International Commercial Centre
    FOREIGN Main Street Gibraltar
    Geschäftsführer
    PO BOX 561 Pmb 6/805
    International Commercial Centre
    FOREIGN Main Street Gibraltar
    BritishDirector38254250001
    KERR, Diane Catherine
    The Cottage
    Back Lane
    NN14 4AX Little Addington
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Cottage
    Back Lane
    NN14 4AX Little Addington
    Northamptonshire
    United KingdomBritishBookseller72001350001
    LOWTHER, David John
    12 Pensford Avenue
    Kew
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    12 Pensford Avenue
    Kew
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    BritishChartered Accountant43607630001
    MELODY, Roger James
    30 Highfield Road
    CR8 2JG Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    30 Highfield Road
    CR8 2JG Purley
    Surrey
    BritishFinance Director17422210001
    PERRY, Terence John
    4 Badgers Croft
    Leverstock Green
    HP2 4NE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Badgers Croft
    Leverstock Green
    HP2 4NE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishTrading Director116319520001
    REDINGTON, John William
    19 Welcomes Road
    CR8 5HA Kenley
    Surrey
    Geschäftsführer
    19 Welcomes Road
    CR8 5HA Kenley
    Surrey
    BritishChartered Accountant65211420001
    SURRIDGE, Stephen Edward
    79 Rook Lane
    CR3 5BN Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    79 Rook Lane
    CR3 5BN Caterham
    Surrey
    BritishDirector-Wholesale Newsagents69814210001
    TOWNLEY, John Robert
    136 Coldershaw Road
    W13 9DT London
    Geschäftsführer
    136 Coldershaw Road
    W13 9DT London
    BritishOperations Director72000900002
    WOOD, Adrian Lewis
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector53930680002
    WOOD, Adrian Lewis
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector53930680002
    WOOD, Adrian Lewis
    7 Ullswater Crescent
    SW15 3RG London
    Geschäftsführer
    7 Ullswater Crescent
    SW15 3RG London
    BritishAccountant53930680001

    Hat SURRIDGE DAWSON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 08. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Frontline Limited
    Transaktionen
    • 08. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern & Shell PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern & Shell Distribution Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern & Shell Magazines Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Associated Newspapers Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Guardian News & Media Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Conde Nast & National Magazine Distributors Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marketforce (UK) Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mgn Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Express Newspapers
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Seymour Distribution Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Telegraph Media Group Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Aug. 2007
    Geliefert am 01. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 16. Mai 2006
    Geliefert am 19. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The amount from time to time standing to the credit of a seperate designated interest earning account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Harmsworth Pension Funds Trustees Limited
    Transaktionen
    • 19. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Nov. 2001
    Geliefert am 05. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Nov. 2000
    Geliefert am 23. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any of the secured parties (as defined) on any account whatsoever and under this guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Jan. 1998
    Geliefert am 26. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the financing documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Okt. 1991
    Geliefert am 23. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The performance of the company's obligations to the chargee under the terms of an agreement dated 24/10/91
    Kurze Angaben
    F/H property off the south side of wainfleet road and to the east of robin hood rd, skegness lincolnshire.
    Berechtigte Personen
    • Wright (Properties) Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 30. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Series of debentures
    Erstellt am 17. Feb. 1987
    Geliefert am 17. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Kurze Angaben
    New windsor bridge road,bath.motts lane witham braintree.holmbush industrial estate, st.austell cornwall.
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1987Registrierung einer Belastung zur Sicherung einer Serie von Schuldverschreibungen (397)
    • 13. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Series of debentures
    Erstellt am 17. Feb. 1987
    Geliefert am 17. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Kurze Angaben
    New windsor bridge road,bath.motts lane, witham braintree.holmbush industrial estate, st.austell cornwell.
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1987Registrierung einer Belastung zur Sicherung einer Serie von Schuldverschreibungen (397)
    • 13. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SURRIDGE DAWSON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Aug. 2009Beginn der Verwaltung
    06. Aug. 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    06. Aug. 2010Beginn der Liquidation
    17. Aug. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0