CHEMRING EUROPE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CHEMRING EUROPE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00746603 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHEMRING EUROPE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CHEMRING EUROPE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHEMRING EUROPE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PARKWAY NO 4 LIMITED | 18. Apr. 2007 | 18. Apr. 2007 |
MCMURDO LIMITED | 25. Sept. 1989 | 25. Sept. 1989 |
MCMURDO INSTRUMENT COMPANY LIMITED(THE) | 11. Jan. 1963 | 11. Jan. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEMRING EUROPE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHEMRING EUROPE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Feb. 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Nov. 2022
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 6 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2021 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserkl ärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Flowers als Geschäftsführer am 30. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHEMRING EUROPE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLARD, Sarah Louise | Sekretär | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | Company Secretary | 43855640011 | |||||
ELLARD, Sarah Louise | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Group Legal Director | 43855640013 | ||||
LEWIS, Andrew Gregory | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 222848510001 | ||||
EDGE, Geoffrey | Sekretär | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Sekretär | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Sekretär | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
ASHER, Kenneth Robert | Geschäftsführer | Chemring House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 121877530001 | ||||
AVERY, John Leonard | Geschäftsführer | Chemring House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 82512570001 | ||||
BILLINGTON, Philip Gordon | Geschäftsführer | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | Chairman | 18247670001 | |||||
BOWERS, Steven John | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 176189250001 | ||||
CLEARY, Michael John | Geschäftsführer | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1525670001 | |||||
DERBYSHIRE, Peter Walter | Geschäftsführer | Red Post Farm Red Post Lane SP11 8DA Andover Hants | British | Manager | 31574890001 | |||||
EVANS, David Roger | Geschäftsführer | Yoxhall Lodge 10 Worsley Road PO5 3DY Southsea Hampshire | England | British | Chief Executive | 4471420003 | ||||
FLOWERS, Michael James | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 188873370002 | ||||
GIBBS, Raymond John | Geschäftsführer | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | Finance Director & Company Sec | 85421380001 | |||||
HAYTER, Timothy William | Geschäftsführer | 7 Salters Acres Stockbridge Road SO22 5JW Winchester | British | Chief Operating Officer | 78917440003 | |||||
HELLYAR, Stuart Thomas | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Financial Controller | 109868650001 | ||||
HELME, Michael John | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | England | British | Professional Engineer | 91910030002 | ||||
HILL, Robert Seamus | Geschäftsführer | Heathwood 6 Ranvilles Lane PO14 3DS Fareham Hampshire | England | British | Managin Director | 59194350001 | ||||
HOFFMAN, Christopher Paul | Geschäftsführer | 20 Hispano Avenue Whiteley PO15 7DS Fareham Hampshire | British | Technical Director | 67353960001 | |||||
JAMES, Ben Luke | Geschäftsführer | Chemring House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 136637830001 | ||||
LYNN, John James | Geschäftsführer | House On The Corner Cricklade Street, Poulton GL7 5HW Cirencester Gloucestershire | British | Managing Director | 69883500001 | |||||
MULLINS, Gary | Geschäftsführer | 8c Langstone Avenue PO9 1RU Havants Hampshire | England | British | Business Director Marine Produ | 102753040001 | ||||
PAPWORTH, Mark Harry | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 103085690002 | ||||
PRICE, David John | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 75259760004 | ||||
RAYNER, Paul Adrian | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
SMITH, Brian John | Geschäftsführer | Haystacks 2 St Albans Close Bishopdown Farm SP1 3FN Salisbury Wiltshire | British | Manager | 57938750001 | |||||
WHITEHORN, Justin Michael | Geschäftsführer | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Director | 42825970001 | ||||
WILLINGHAM, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | 64 New Forest Drive SO42 7QW Brockenhurst Hampshire | British | Manager | 31574880001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHEMRING EUROPE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemring Group Plc | 30. Juni 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CHEMRING EUROPE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2010 Geliefert am 13. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Nov. 2009 Geliefert am 30. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Nov. 2007 Geliefert am 20. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 05. Feb. 2001 Geliefert am 14. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 22. Dez. 1997 Geliefert am 02. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over book debts | Erstellt am 06. Dez. 1994 Geliefert am 14. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank all monies which it may receive in respect of such debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 29. Apr. 1993 Geliefert am 06. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 19. Okt. 1990 Geliefert am 05. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital those mentioned above). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Okt. 1990 Geliefert am 05. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0