WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00749317 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
- Reisebüroaktivitäten (79110) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Ernst & Young Llp 2 St. Peters Square M2 3EY Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DATA SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED | 06. Feb. 1963 | 06. Feb. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 41 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 40 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 41 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 41 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 43 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 49 Seiten | AM10 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard James Calvert als Geschäftsführer am 29. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul David Smith als Geschäftsführer am 17. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 4 Seiten | AM06 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 8 Seiten | AM02 | ||
Vorschlag des Verwalters | 90 Seiten | AM03 | ||
Beendigung der Bestellung von a G Secretarial Limited als Sekretär am 22. Mai 2020 | 2 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom zum C/O Ernst & Young Llp 2 st. Peters Square Manchester M2 3EY am 09. Juni 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gary Speakman als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Paul David Smith als Direktor am 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Vincent Flower als Geschäftsführer am 01. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Graham John Rogers am 12. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGERS, Graham John | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 69494710002 | ||||||||
BELL, Richard William | Sekretär | Hadleigh House 128a Skipton Road LS29 9BQ Ilkley West Yorkshire | British | 1124760001 | ||||||||||
HINSLIFF, Robert | Sekretär | 30 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | 51000070001 | ||||||||||
MEDDES, Kenneth Sydney | Sekretär | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | British | Company Director | 11486330002 | |||||||||
THOMAS, Joan Valerie | Sekretär | 3 Broom Road LS24 9LH Tadcaster North Yorkshire | British | 51418740001 | ||||||||||
TURNER, Jayne Marie | Sekretär | 33 Dingleway Appleton WA4 3AB Warrington Cheshire | British | Accountant | 117561640001 | |||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
BARR, John Malcolm | Geschäftsführer | Kirkby House Kirkby Overblow HG3 1HJ Harrogate North Yorkshire | British | Chairman | 33219550001 | |||||||||
BARR, Nicholas Stuart | Geschäftsführer | Mouse Hall Galphay HG4 3NT Ripon North Yorkshire | British | Director | 53565740001 | |||||||||
BARR, Robert Adam | Geschäftsführer | Crow House Farm Burton Leonard HG3 3SX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 28813320001 | ||||||||
BARR, Stuart Alan | Geschäftsführer | The Royal Hunting Lodge Shipton YO6 1BD Beningborough York | British | Group Managing Director | 509420001 | |||||||||
BELL, Richard William | Geschäftsführer | Hadleigh House 128a Skipton Road LS29 9BQ Ilkley West Yorkshire | England | British | Finance Director | 1124760001 | ||||||||
BURKE, Jane Bain | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 51003380001 | ||||||||
CALVERT, Richard James | Geschäftsführer | 2 St. Peters Square M2 3EY Manchester C/O Ernst & Young Llp | England | British | Ceo | 163434180002 | ||||||||
CONNOR, Ruth Joanne | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire England | England | British | Managing Director | 154083710001 | ||||||||
FLOWER, Vincent | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 91542970002 | ||||||||
FREEMAN, Paul Stephen | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | British | Accountant | 52600500001 | |||||||||
GEE, Karen | Geschäftsführer | 28 Pear Tree Drive Farnworth BL4 9RR Bolton Lancashire | British | Company Director | 95873280004 | |||||||||
KING, William John | Geschäftsführer | Wheelgate House Reedness DN14 8ER Goole North Humberside | England | British | Managing Director | 35518260001 | ||||||||
MACLEAN, Alan Kenneth | Geschäftsführer | Teston Road ME19 5NJ Offham The Old Forge Kent | United Kingdom | British | Commercial Director | 130948230001 | ||||||||
MALLALIIEU, Simon | Geschäftsführer | Beech House 45 Parish Ghyll Drive LS29 9PR Ilkley West Yorkshire | British | Director | 46919850001 | |||||||||
MEDDES, Kenneth Sydney | Geschäftsführer | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | Accountant | 11486330002 | ||||||||
NEWBOLD, David Robert | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 30276880001 | ||||||||
NORMAN, Bernard Robert | Geschäftsführer | Brackley House Marholm Road Ufford PE9 3BL Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Director | 65467300001 | ||||||||
O'CALLAGHAN, Joseph | Geschäftsführer | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | England | British | Director | 110216340001 | ||||||||
PARKER, John Francis | Geschäftsführer | Beck House 10 Fulwith Mill Lane HG2 8HJ Harrogate North Yorkshire | British | Director And Chief Executive | 47002780001 | |||||||||
SLATCHER, David John | Geschäftsführer | 3 Brindle Heights Water Street Brindle PR6 8YA Chorley Lancashire | British | Company Director | 104434750001 | |||||||||
SMALL, Brian Michael | Geschäftsführer | Laithe Croft Totties Lane HD1 1UL Holmfirth West Yorkshire | British | Company Director | 45198750001 | |||||||||
SMITH, Paul David | Geschäftsführer | Waterside Drive Wigan Pier Business Park WN3 5AZ Wigan C/O Specialist Leisure Group, Waterside House United Kingdom | England | British | Accountant | 228581750001 | ||||||||
SPEAKMAN, Gary | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Finance Director | 56066860001 | ||||||||
SPETCH, Paul Anthony | Geschäftsführer | Rivelin Common Lane Warthill YO19 5XL York | England | British | Financial Director | 51421190001 | ||||||||
WORMWELL, Denis | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 124681340001 | ||||||||
WORSNUP, Peter Jonathan | Geschäftsführer | 12 Grantley Place Bradley HD2 1LZ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 95865490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shearings Group Limited | 06. Apr. 2016 | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and set-off agreement | Erstellt am 20. Apr. 2006 Geliefert am 05. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its credit balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Apr. 2006 Geliefert am 05. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 30. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite cross guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 02. Okt. 2001 Geliefert am 18. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Aug. 1997 Geliefert am 30. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities (whether present or future actual or contingent) now or at any time or times hereafter due or owing or incurred by the company (whether as principal or security) to the chargee or any of the investors (as that terms is defined in the charge) pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 15. Aug. 1997 Geliefert am 19. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities for the time being due, owing or incurred by the company and/or wallace arnold group limited to the chargee under or in connection with the finance documents and/or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Apr. 1981 Geliefert am 22. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All subhiring agreements entered into atany time and customers of the mortgager relating to goods owned by the mortgageebut let by the mortgagee to the mortgager under leasing agreements entered into by the mortgagee and mortgagor and the monies payable under such sub-hiring agreements. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat WALLACE ARNOLD TRAVEL LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0