F.A. DAVIS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | F.A. DAVIS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00750306 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von F.A. DAVIS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich F.A. DAVIS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Clc Group Ltd Unit 2 Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von F.A. DAVIS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| F.A.DAVIS(PAINTING CONTRACTOR)LIMITED | 15. Feb. 1963 | 15. Feb. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von F.A. DAVIS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für F.A. DAVIS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Benjamin Thomas Armitage am 01. Juni 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Malcolm John White am 01. Juni 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Malcolm John White am 01. Juni 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von F.A. DAVIS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Malcolm John | Sekretär | Unit 2 Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton C/O Clc Group Ltd Hampshire | British | 110398690002 | ||||||
| ARMITAGE, Peter Benjamin Thomas | Geschäftsführer | Unit 2 Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton C/O Clc Group Ltd Hampshire | England | British | 72943340002 | |||||
| WHITE, Malcolm John | Geschäftsführer | Unit 2 Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton C/O Clc Group Ltd Hampshire | United Kingdom | British | 110398690002 | |||||
| EAVES, Terence Joseph | Sekretär | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | British | 125796830001 | ||||||
| GLEAVE, Linda Margaret | Sekretär | 34 Guilford Road Stoneygate LE2 2RD Leicester Leicestershire | British | 54111520001 | ||||||
| ILES, Mark Willmott | Sekretär | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | British | 23509110002 | ||||||
| JOHNSON, Ian Edward | Sekretär | 71 Leicester Road Oadby LE2 4DF Leicester Leicestershire | British | 14396620001 | ||||||
| MATHERS, Stephen | Sekretär | 8 Kingfisher Close LE8 9DG Great Glen Leicester | British | 73169370001 | ||||||
| THOMAS, Geoffrey | Sekretär | 19 Main Street Houghton On The Hill LE7 9GE Leicester Leicestershire | British | 13949310001 | ||||||
| EAVES, Terence Joseph | Geschäftsführer | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | England | British | 125796830001 | |||||
| GLEAVE, Linda Margaret | Geschäftsführer | 34 Guilford Road Stoneygate LE2 2RD Leicester Leicestershire | British | 54111520001 | ||||||
| HILTON, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Lindisfarne 7 Longford Park TF10 8LW Newport Shropshire | England | British | 97484770001 | |||||
| ILES, Mark Willmott | Geschäftsführer | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 23509110002 | |||||
| JACKSON, John Stephen | Geschäftsführer | 24 Nest Common Pelsall WS3 5AZ Walsall West Midlands | British | 14627530001 | ||||||
| JOHNSON, Ian Edward | Geschäftsführer | 71 Leicester Road Oadby LE2 4DF Leicester Leicestershire | British | 14396620001 | ||||||
| ROBERTS, David Michael | Geschäftsführer | 63 Hednesford Road Heath Hayes WS12 5HL Cannock Staffordshire | British | 44159250001 | ||||||
| SAVAGE, Hilda Margaret | Geschäftsführer | Powers Court Southmeads Road LE2 2LR Leicester Leicestershire | British | 39947410001 | ||||||
| SAVAGE, James Edward | Geschäftsführer | Powers Court Southmeads Road LE2 2LR Leicester Leicestershire | British | 8358250001 | ||||||
| STEEL, Christopher William | Geschäftsführer | 193 Cannock Road Westcroft WV10 8QL Wolverhampton | England | British | 44159190001 | |||||
| THOMAS, Geoffrey | Geschäftsführer | 19 Main Street Houghton On The Hill LE7 9GE Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 13949310001 |
Hat F.A. DAVIS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Dez. 2004 Geliefert am 21. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2000 Geliefert am 15. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Juni 1995 Geliefert am 19. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1993 Geliefert am 01. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Aug. 1993 Geliefert am 01. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of mill hill road hinckley. T/n-LT187634. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Jan. 1990 Geliefert am 26. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of mill hill rd, hinckley leicestershire title no lt 187634. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 1988 Geliefert am 01. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0