MOUNTGRANGE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOUNTGRANGE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00752243
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOUNTGRANGE LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich MOUNTGRANGE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O DELOITTE LLP
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOUNTGRANGE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MOUNTGRANGE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOUNTGRANGE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. März 2015

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 16. März 2015

    20 Seiten2.35B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    5 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2014

    23 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. März 2014

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2013

    25 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. März 2013

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2012

    42 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. März 2012

    50 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2011

    39 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2010

    40 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. März 2011

    42 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. März 2010

    43 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    2 Seiten2.31B

    Beendigung der Bestellung von Stephen Corner als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Berry als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Manish Chande als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Berry als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2009

    1 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Martin Myers als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MOUNTGRANGE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BERRY, Nicholas Anthony
    Hilltop Cottage
    Stanmore
    RG20 8SR Chievley
    Berkshire
    Sekretär
    Hilltop Cottage
    Stanmore
    RG20 8SR Chievley
    Berkshire
    British82162010002
    DU SAUTOY, Marianne Elizabeth
    12a Evelyn Road
    W4 5JL London
    Sekretär
    12a Evelyn Road
    W4 5JL London
    British51379450002
    DWIGHT, Rochelle
    8 Heathside Close
    Newbury Park
    IG2 7PD Ilford
    Essex
    Sekretär
    8 Heathside Close
    Newbury Park
    IG2 7PD Ilford
    Essex
    British90394180001
    MYERS, Nicole Josephine
    1 Durham Place
    SW3 4ET London
    Sekretär
    1 Durham Place
    SW3 4ET London
    British6948210001
    WORLEY, Evelyn
    15 Forest Ridge
    BR3 3NH Beckenham
    Kent
    Sekretär
    15 Forest Ridge
    BR3 3NH Beckenham
    Kent
    British42995400001
    BERRY, Nicholas Anthony
    Hilltop Cottage
    Stanmore
    RG20 8SR Chievley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Hilltop Cottage
    Stanmore
    RG20 8SR Chievley
    Berkshire
    EnglandBritish82162010002
    CHANDE, Manish Jayantilal
    Royal Avenue
    SW3 4QF London
    16
    Geschäftsführer
    Royal Avenue
    SW3 4QF London
    16
    UkBritish83291490003
    CORNER, Stephen Ashley
    Cortleigh
    Bakers Wood
    UB9 4LQ Denham
    Uxbridge
    Geschäftsführer
    Cortleigh
    Bakers Wood
    UB9 4LQ Denham
    Uxbridge
    EnglandBritish40334000004
    MYERS, Martin Trevor
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    Geschäftsführer
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    EnglandBritish35819830001

    Hat MOUNTGRANGE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 17. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A fixed equitable charge over the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Pollen Estate Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Intercreditor deed
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 18. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The investor debt, and any payment or distribution of any kind and all and any rights in respect thereof whether in cash,securities or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Intercreditor deed
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 18. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £16,000,000 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    The investor debt, and any payment or distribution of any kind and all and any rights in respect thereof whether in cash,securities or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Lender)
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Intercreditor deed
    Erstellt am 21. Dez. 2005
    Geliefert am 30. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    If any insolvency event occurs then the investor debt will be postponed to the bos debt and each of the investors will file any proof or other claim necessary for the recovery of the investor debt; any payment or distribution and all any rights in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Aug. 2003
    Geliefert am 28. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 02. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 15 lyall mews london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 02. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 15 lyall mews london t/no NGL534145. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. März 2001
    Geliefert am 12. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease (as defined)
    Kurze Angaben
    The interest in the deposit account (as defined), the deposit being £11,595.06 plus any vat thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mid U.K.Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. März 2001
    Geliefert am 12. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease (as defined)
    Kurze Angaben
    The interest in the deposit account (as defined),the deposit being £11,595.06 plus vat thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mid U.K.Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 1998
    Geliefert am 07. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 15 lyall mews belgravia london t/no;-NGL596271.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Shares pledge
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 07. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    500 ordinary shares held in mychand holdings limited and the proceeds of sale thereof together with all dividends interest and other monies and all rights accruing thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Letter of pledge
    Erstellt am 30. Okt. 1997
    Geliefert am 05. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    400,000 ordinary shares of 50,pence each in marylebone warwick balfour group PLC together with all dividends right title and accreations thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1986
    Geliefert am 20. März 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1. all & every interest in or over flat 5 waveney house ormonde gate london SW3 T.N. ngl 448635 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juni 1973
    Geliefert am 15. Juni 1973
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    166 high street watford.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1973Registrierung einer Belastung

    Hat MOUNTGRANGE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. März 2009Beginn der Verwaltung
    16. März 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Charles Reid
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Carlton Malcolm Siddle
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ian Colin Wormleighton
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0