WOOL PROCESSORS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOOL PROCESSORS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00752537
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOOL PROCESSORS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    2 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Barbara Modiano als Geschäftsführer am 05. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    5 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 30 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 21. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 007525370033, erstellt am 14. Juli 2015

    34 SeitenMR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Barbara Modiano am 22. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 26. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Giuseppe Modiano als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARSONS, Russell Thomas
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Sekretär
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    170919930001
    MODIANO, Michael
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Geschäftsführer
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    United KingdomItalian102968310001
    PARSONS, Russell Thomas
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Geschäftsführer
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    EnglandBritish75173990005
    AARVOLD, John Merriman
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    British19645650001
    AARVOLD, John Merriman
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish19645650001
    BENTLEY, Robert Alexander
    7a Prod Lane
    Baildon
    BD17 5BN Shipley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7a Prod Lane
    Baildon
    BD17 5BN Shipley
    West Yorkshire
    EnglandBritish12692920001
    DALLAS, John Eastwood
    28 Lennox Gardens
    SW1X 0DQ London
    Geschäftsführer
    28 Lennox Gardens
    SW1X 0DQ London
    United KingdomBritish10487030002
    LOWE, Peter James
    Rhiwisg
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YE Ruthin
    Clwyd
    Wales
    Geschäftsführer
    Rhiwisg
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YE Ruthin
    Clwyd
    Wales
    British45586640001
    MODIANO, Barbara
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Geschäftsführer
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    EnglandItalian16420950001
    MODIANO, Giuseppe
    7 Mulberry Walk
    SW3 6DZ London
    Geschäftsführer
    7 Mulberry Walk
    SW3 6DZ London
    United KingdomItalian16420940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    G Modiano Ltd
    Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    55
    England
    06. Apr. 2016
    Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    55
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House, Cardiff
    Registrierungsnummer00872284
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat WOOL PROCESSORS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 14. Juli 2015
    Geliefert am 17. Juli 2015
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A group guarantee and floating charge
    Erstellt am 07. Jan. 2011
    Geliefert am 10. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any other company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all its assets. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A group guarantee and floating charge
    Erstellt am 18. Aug. 2010
    Geliefert am 23. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any other company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all assets being all the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company, whatsoever and wheresoever present and future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 14. Juni 1999
    Geliefert am 25. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and all monies and liabilities due or to become due from any other members of the group to the chargee except any monies or liabilities due owing or incurred by such other member of the group as guarantor for the company
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all its undertaking property rights claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag (Amsterdam Branch)
    Transaktionen
    • 25. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 1998
    Geliefert am 05. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a chattels mortgage dated 30 december 1996
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over those items listed on the schedule attached to the 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 02. Sept. 1998
    Geliefert am 11. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a chattles mortgage dated 30TH december 1996
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge over those items lisited in the schedule attached to the form 395. floating charge over those items listed in the schedule attached to the form 395 if and insofar as the fixed charge shall for any reason be ineffective.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 11. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 04. Juli 1997
    Geliefert am 08. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a chattels mortgage dated 30TH december 1996
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over those items listed in the annexed schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 08. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 30. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 20TH september 1996,this mortgage and any supplemental charge
    Kurze Angaben
    The chattels,plant,machinery specified in the schedule and the floating charge over the chattels referred therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Ap Bank Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 02. Feb. 1996
    Geliefert am 06. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All undertaking property and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banca Nazionale Del Lavoro
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 02. Feb. 1996
    Geliefert am 06. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking property rights claims and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Francaise Du Commerce Exterieur
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 21. Nov. 1994
    Geliefert am 05. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nedcor Bank Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 21. Nov. 1994
    Geliefert am 05. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banco Central Hispanoamericano Sa
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 21. Nov. 1994
    Geliefert am 05. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Henry Ansbacher & Co.Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 21. Feb. 1994
    Geliefert am 25. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Ba
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 27. Jan. 1993
    Geliefert am 04. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M616C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank Mees & Hope N.V.
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Agreement of release accession and supplemental charge
    Erstellt am 29. Juli 1991
    Geliefert am 06. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the german security dated 17TH aug 1990 and this deed
    Kurze Angaben
    The existing and future collateral of the company as charged by the german security.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group guarantee & floating charge
    Erstellt am 29. Juli 1991
    Geliefert am 31. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • H. Albert De Bary & Co Nv
    Transaktionen
    • 31. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 28. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 1990
    Geliefert am 24. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this charge.
    Kurze Angaben
    The company's ownership and interest in the stock of such wool and wollenmaterials (the "collateral") from time to time in the area of the bremer woll - kammerei and K.E.s frachtkontor gmbh (the "security area") (see 395 ref M172 a nd cont'd) sheets for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 28. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group guarantee & floating charge
    Erstellt am 02. März 1990
    Geliefert am 13. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 13. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of variation
    Erstellt am 18. Jan. 1990
    Geliefert am 30. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Thereby certify that a deed of variation dated 18 jan 1990 and created by wool processing limited for varying the terms of a group guarantee and floating charge dated 4 july 88
    Kurze Angaben
    As detailed in group guarantee and floating charge dated 4TH july 1988.
    Berechtigte Personen
    • Banque Indosuez
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 04. Juli 1988
    Geliefert am 05. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M317 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 05. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 04. Juli 1988
    Geliefert am 05. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M312 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Riggs A.P. Bank Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 13. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 04. Juli 1988
    Geliefert am 05. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M287 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 04. Juli 1988
    Geliefert am 05. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M282 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Hongkong & Shanghai Banking Corporation
    Transaktionen
    • 05. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    Group guarantee and floating charge
    Erstellt am 04. Juli 1988
    Geliefert am 05. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M277 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Citibank Na
    Transaktionen
    • 05. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0