SHEARINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SHEARINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00753110 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SHEARINGS LIMITED?
- Sonstiger Personenlandverkehr im Stadt-, Vorort- oder Ballungsraum (nicht U-Bahn, Metro oder ähnlich) (49319) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich SHEARINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Ernst & Young Llp 2 St. Peters Square M2 3EY Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SHEARINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WA SHEARINGS LIMITED | 13. März 2006 | 13. März 2006 |
SHEARINGS LIMITED | 24. Okt. 1989 | 24. Okt. 1989 |
SMITHS SHEARINGS LIMITED | 25. Feb. 1987 | 25. Feb. 1987 |
SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED | 17. Dez. 1984 | 17. Dez. 1984 |
JACKSONS OF ALTRINCHAM LIMITED | 12. März 1963 | 12. März 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHEARINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SHEARINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 41 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 40 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 41 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 41 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 43 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Beendigung der Bestellung von Christopher Brown als Geschäftsführer am 22. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 49 Seiten | AM10 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard James Calvert als Geschäftsführer am 29. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul David Smith als Geschäftsführer am 17. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 4 Seiten | AM06 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 20 Seiten | AM02 | ||
Vorschlag des Verwalters | 90 Seiten | AM03 | ||
Beendigung der Bestellung von a G Secretarial Limited als Sekretär am 22. Mai 2020 | 2 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom zum C/O Ernst & Young Llp 2 st. Peters Square Manchester M2 3EY am 10. Juni 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 30 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gary Speakman als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Paul David Smith als Direktor am 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Vincent Flower als Geschäftsführer am 01. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 28 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SHEARINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGERS, Graham John | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 69494710002 | ||||
DOCKRELL, Carol Ann | Sekretär | 77 St Marys Drive SS7 1LH Benfleet Essex | British | 26244410001 | ||||||
HINSLIFF, Robert | Sekretär | 30 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | Chief Accountant | 51000070001 | |||||
THOMAS, Francis George Northcott | Sekretär | Sandfield Cottage St Nicolas Lane BR7 5LL Chislehurst Kent | British | 34191470001 | ||||||
TURNER, Jayne Marie | Sekretär | 33 Dingleway Appleton WA4 3AB Warrington Cheshire | British | Accountant | 117561640001 | |||||
WATKINS, Simon Andrew | Sekretär | 6 Errington Close Chadwell St Mary RM16 4TA Grays Essex | British | 34048840001 | ||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom | 90084920001 | |||||||
BROWN, Christopher | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | British | Operations Director | 138681610001 | |||||
BURKE, Jane Bain | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 51003380001 | ||||
CALVERT, Richard James | Geschäftsführer | 2 St. Peters Square M2 3EY Manchester C/O Ernst & Young Llp | England | British | Ceo | 163434180002 | ||||
CONNOR, Ruth Joanne | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire England | England | British | Managing Director | 154083710001 | ||||
CRICHTON-MILLER, Hugh Angus | Geschäftsführer | Woodspeen West Lambourn Road Woodspeen RG20 8BU Newbury Berkshire | British | Director | 16687350001 | |||||
FLOWER, Vincent | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 91542970002 | ||||
FREEMAN, Paul Stephen | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | British | Accountant | 52600500001 | |||||
HILTON, Peter | Geschäftsführer | 20 Doeford Close Culcheth WA3 4DL Warrington Cheshire | British | Operations Manager | 51002110001 | |||||
HINSLIFF, Robert | Geschäftsführer | 30 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | Chief Accountant | 51000070001 | |||||
KING, James Hughie | Geschäftsführer | 2 Lumbrook Close Coley HX3 7UD Halifax West Yorkshire | British | Tour Director | 51002070003 | |||||
NEWBOLD, David Robert | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 30276880001 | ||||
NORTH, Terence Henry | Geschäftsführer | 1 Ambleside Kendal Avenue CM16 4PT Epping Essex | British | Director | 33990450001 | |||||
OWERS, Brian Charles | Geschäftsführer | 19 Wilmot Way GU15 1JA Camberley Surrey | England | British | Director | 34009090001 | ||||
SLATCHER, David John | Geschäftsführer | 3 Brindle Heights Water Street Brindle PR6 8YA Chorley Lancashire | British | Director | 104434750001 | |||||
SMITH, Paul David | Geschäftsführer | Waterside Drive Wigan Pier Business Park WN3 5AZ Wigan C/O Specialist Leisure Group, Waterside House United Kingdom | England | British | Accountant | 228581750001 | ||||
SPEAKMAN, Gary | Geschäftsführer | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Finance Director | 56066860001 | ||||
THOMAS, Francis George Northcott | Geschäftsführer | Sandfield Cottage St Nicolas Lane BR7 5LL Chislehurst Kent | England | British | Chartered Accountant | 34191470001 | ||||
WORMWELL, Denis | Geschäftsführer | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 124681340001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SHEARINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shearings Holidays Limited | 06. Apr. 2016 | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SHEARINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and set-off agreement | Erstellt am 20. Apr. 2006 Geliefert am 05. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its credit balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Apr. 2006 Geliefert am 05. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Coach asset chattel mortgage | Erstellt am 11. Apr. 2005 Geliefert am 18. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Coach assets being make jonckheere mistral registration numbers 4WA, Y705 wt and Y706HWT for further details of chattels charged please refer to 395. all right, title, benefit and interest in and to all insurances, the benefit of all contracts and agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 11. Apr. 2005 Geliefert am 13. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The equipment being jonckheere mistral coach, reg. No. Y701 hwt; jonckheere mistral coach, reg. No.Y702 hwt; jonckheere mistral coach, reg. No. Y703 hwt. For details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 30. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 12. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant machinery and items listed below or any part thereof.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 09. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Equipment as set out in schedule to form 395 headed by volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg. Date mar.02, Fleet no.423 Reg. No.MV02 uln chassis no.285 Body no.33689, Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg. Date mar.02, Fleet no.424 Reg.no. MV02 ulo chassis no. 286 body no.33690, Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg.date mar 02, fleet no.425 Reg.no., MV02ULP chassis no.287 Body no.33691 And all policies of insurance in respect thereof and all options and rights therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 04. Nov. 2002 Geliefert am 14. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 427; reg no MV02 uls; chassis no: 289; body no: 33693. volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 428; reg no MV02 ult; chassis no: 292; body no: 33694. volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 429; reg no MV02 ulu; chassis no: 293; body no: 33695. (for further goods charged refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 04. Nov. 2002 Geliefert am 14. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns the goods described in the schedule attached to the form 395: volvo B12M reg no MV02 umj; volvo BM12M reg no MV02 umk; volvo B12M reg no MV02 uml and others as described, and the tyres (as described) together with the benefit of contracts for sale, acquisition or refurbishment of the goods. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Nov. 2002 Geliefert am 12. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interchange bayton road bayton rd industrial est exhall t/n WK123054. Interchange mill lane normanton industrial est west yorkshire t/n's WYK529098, WYK546441 and WYK444848. Interchange barleycastle lane stretton warrington t/n CH395349. For details of further property charged please refer to form 395, fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Dez. 1996 Geliefert am 24. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben (I) f/hold property known as winifred garage and adjoining land/blds at winifred road and charles st,skewen neath; t/nos: wa 667364,wa 747246,wa 690438 (possessory t/no); (ii) f/hold land on east side of barleycastle lane,appleton; ch 395349; (iii) f/hold property known as land to the east side of mill lane,normanton; t/nos: wyk 444848,wyk 529098 and wyk 546441 plus 4 other properties listed; all proceeds of sale thereof;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equipment mortgage | Erstellt am 18. Dez. 1996 Geliefert am 24. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben The equipment as listed with all rights,title,benefit and interest and all insurances thereby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 18. Dez. 1996 Geliefert am 24. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured parties (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed | Erstellt am 17. Feb. 1982 Geliefert am 25. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a deenture dted 31ST may 1968 | |
Kurze Angaben All book debts and other debts present & future . | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SHEARINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0