SHEARINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSHEARINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00753110
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SHEARINGS LIMITED?

    • Sonstiger Personenlandverkehr im Stadt-, Vorort- oder Ballungsraum (nicht U-Bahn, Metro oder ähnlich) (49319) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich SHEARINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Ernst & Young Llp
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SHEARINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WA SHEARINGS LIMITED13. März 200613. März 2006
    SHEARINGS LIMITED24. Okt. 198924. Okt. 1989
    SMITHS SHEARINGS LIMITED25. Feb. 198725. Feb. 1987
    SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED17. Dez. 198417. Dez. 1984
    JACKSONS OF ALTRINCHAM LIMITED12. März 196312. März 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHEARINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SHEARINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    41 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    40 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    41 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    41 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    43 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Beendigung der Bestellung von Christopher Brown als Geschäftsführer am 22. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    49 SeitenAM10

    Beendigung der Bestellung von Richard James Calvert als Geschäftsführer am 29. Mai 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul David Smith als Geschäftsführer am 17. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenAM06

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    20 SeitenAM02

    Vorschlag des Verwalters

    90 SeitenAM03

    Beendigung der Bestellung von a G Secretarial Limited als Sekretär am 22. Mai 2020

    2 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom zum C/O Ernst & Young Llp 2 st. Peters Square Manchester M2 3EY am 10. Juni 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    30 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Gary Speakman als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Paul David Smith als Direktor am 01. Okt. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Vincent Flower als Geschäftsführer am 01. Okt. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    28 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SHEARINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROGERS, Graham John
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director69494710002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Sekretär
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Sekretär
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishChief Accountant51000070001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Sekretär
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    WATKINS, Simon Andrew
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    Sekretär
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    British34048840001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Sekretär
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    BROWN, Christopher
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishOperations Director138681610001
    BURKE, Jane Bain
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51003380001
    CALVERT, Richard James
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    C/O Ernst & Young Llp
    Geschäftsführer
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    C/O Ernst & Young Llp
    EnglandBritishCeo163434180002
    CONNOR, Ruth Joanne
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    England
    EnglandBritishManaging Director154083710001
    CRICHTON-MILLER, Hugh Angus
    Woodspeen West Lambourn Road
    Woodspeen
    RG20 8BU Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Woodspeen West Lambourn Road
    Woodspeen
    RG20 8BU Newbury
    Berkshire
    BritishDirector16687350001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    FREEMAN, Paul Stephen
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishAccountant52600500001
    HILTON, Peter
    20 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DL Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DL Warrington
    Cheshire
    BritishOperations Manager51002110001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishChief Accountant51000070001
    KING, James Hughie
    2 Lumbrook Close
    Coley
    HX3 7UD Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Lumbrook Close
    Coley
    HX3 7UD Halifax
    West Yorkshire
    BritishTour Director51002070003
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director30276880001
    NORTH, Terence Henry
    1 Ambleside
    Kendal Avenue
    CM16 4PT Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    1 Ambleside
    Kendal Avenue
    CM16 4PT Epping
    Essex
    BritishDirector33990450001
    OWERS, Brian Charles
    19 Wilmot Way
    GU15 1JA Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    19 Wilmot Way
    GU15 1JA Camberley
    Surrey
    EnglandBritishDirector34009090001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishDirector104434750001
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34191470001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SHEARINGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer218550
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SHEARINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 20. Apr. 2006
    Geliefert am 05. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Apr. 2006
    Geliefert am 05. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Coach asset chattel mortgage
    Erstellt am 11. Apr. 2005
    Geliefert am 18. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Coach assets being make jonckheere mistral registration numbers 4WA, Y705 wt and Y706HWT for further details of chattels charged please refer to 395. all right, title, benefit and interest in and to all insurances, the benefit of all contracts and agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 11. Apr. 2005
    Geliefert am 13. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The equipment being jonckheere mistral coach, reg. No. Y701 hwt; jonckheere mistral coach, reg. No.Y702 hwt; jonckheere mistral coach, reg. No. Y703 hwt. For details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2005
    Geliefert am 31. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 31. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2005
    Geliefert am 31. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 31. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2005
    Geliefert am 30. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 12. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the chattels plant machinery and items listed below or any part thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 09. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Equipment as set out in schedule to form 395 headed by volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg. Date mar.02, Fleet no.423 Reg. No.MV02 uln chassis no.285 Body no.33689, Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg. Date mar.02, Fleet no.424 Reg.no. MV02 ulo chassis no. 286 body no.33690, Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg.date mar 02, fleet no.425 Reg.no., MV02ULP chassis no.287 Body no.33691 And all policies of insurance in respect thereof and all options and rights therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ba/Ca Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 04. Nov. 2002
    Geliefert am 14. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 427; reg no MV02 uls; chassis no: 289; body no: 33693. volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 428; reg no MV02 ult; chassis no: 292; body no: 33694. volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 429; reg no MV02 ulu; chassis no: 293; body no: 33695. (for further goods charged refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 04. Nov. 2002
    Geliefert am 14. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigns the goods described in the schedule attached to the form 395: volvo B12M reg no MV02 umj; volvo BM12M reg no MV02 umk; volvo B12M reg no MV02 uml and others as described, and the tyres (as described) together with the benefit of contracts for sale, acquisition or refurbishment of the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finance PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2002
    Geliefert am 12. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interchange bayton road bayton rd industrial est exhall t/n WK123054. Interchange mill lane normanton industrial est west yorkshire t/n's WYK529098, WYK546441 and WYK444848. Interchange barleycastle lane stretton warrington t/n CH395349. For details of further property charged please refer to form 395, fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    (I) f/hold property known as winifred garage and adjoining land/blds at winifred road and charles st,skewen neath; t/nos: wa 667364,wa 747246,wa 690438 (possessory t/no); (ii) f/hold land on east side of barleycastle lane,appleton; ch 395349; (iii) f/hold property known as land to the east side of mill lane,normanton; t/nos: wyk 444848,wyk 529098 and wyk 546441 plus 4 other properties listed; all proceeds of sale thereof;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equipment mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The equipment as listed with all rights,title,benefit and interest and all insurances thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC, as Security Trustee
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured parties (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 15. Juni 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 17. Feb. 1982
    Geliefert am 25. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a deenture dted 31ST may 1968
    Kurze Angaben
    All book debts and other debts present & future .
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1982Registrierung einer Belastung
    • 30. Okt. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SHEARINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Mai 2020Beginn der Verwaltung
    24. Mai 2023Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Colin Peter Dempster
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praktiker
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0